GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED

GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02330098
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3rd Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    Cheshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NC2 LIMITED16 janv. 199216 janv. 1992
    APPFIRE LIMITED20 déc. 198820 déc. 1988

    Quels sont les derniers comptes de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Shona Clare Searle en tant qu'administrateur le 01 juil. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Edward Dennison en tant que directeur le 01 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 09 nov. 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account of the company being £211,800 be cancelled and extinguished in full and it's credited to distributable reserves 26/10/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    19 pagesAA

    Deuxième dépôt pour la nomination de James Edward Dennison en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    18 pagesAA

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 pagesAD04

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Edward Dennison le 31 juil. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Altair Filter Technology Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 juil. 2019

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT le 31 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Daryl Everett en tant que directeur le 24 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de James Edward Dennison en tant qu'administrateur le 24 sept. 2018

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    08 juin 2020Clarification A second filed AP01 was registered on 08/06/2020.

    Cessation de la nomination de Timothy Robert Hill en tant que directeur le 24 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    SEARLE, Shona Clare
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant And Chartered Tax Advisor203330870002
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Secrétaire
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    AmericanDirector111641000001
    HEGARTY, Colin Michael
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    Secrétaire
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    British14062610002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOYCE, Christian Jeremy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSite Leader174484350001
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Administrateur
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    AmericanDirector111641000001
    CARSON, Candace
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    Administrateur
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    AmericanDirector111758740001
    CHURCH, Ian Harold
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    Administrateur
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    BritishDirector1750390002
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishLegal Counsel56868460002
    CLEAVER, Roy Edward
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    BritishDirector21416960002
    DENNISON, James Edward
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Director250786800001
    ELSDON, Peter John
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director Accountant67751830001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    HEINTZELMAN, Daniel
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    Administrateur
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    AmericanGeneral Manager111641060001
    HILL, Timothy Robert
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant183650700001
    HINTON, David Ian Small
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    Administrateur
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector21416950001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Administrateur
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    BritishUk Controller Ge Energy106985300001
    RICHARDSON, Paul
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGlobal Projects Leader174494740001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector203364460001
    SENNETT, Paul Timothy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNone174484310001
    STEEL, Andrew Charles
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    Administrateur
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director33164070002
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Manager96648390001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4543176
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    29 nov. 201601 déc. 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 févr. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H interest in plot 3, omega park, wilsom road, alton, hampshire t/n HP481527. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The South Place Gresham Partnership 2002 Acting as Security Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Freehold property known as plot 3 omega park wilsom road alton hampshire t/n HP481527. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Stock pledge
    Créé le 01 févr. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The entire issued share capital of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 1994
    Livré le 18 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 3 omega park alton hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 sept. 1989
    Livré le 25 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 sept. 1989
    Livré le 02 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0