AVONSIDE ROOFING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAVONSIDE ROOFING LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02330586
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    • Travaux de couverture (43910) / Construction

    Où se situe AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    BEGBIES TRAYNOR
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEE ROOFING SERVICES LIMITED20 janv. 199720 janv. 1997
    LEE ROOFING SERVICES (NORTH WEST) LIMITED21 déc. 198821 déc. 1988

    Quels sont les derniers comptes de AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 août 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 août 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 août 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    72 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    73 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    73 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    52 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    56 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    51 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    29 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    4 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    105 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de The Courtyard Green Lane Heywood Lancashire OL10 2EX à 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR le 15 sept. 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Cessation de la nomination de Anthony Burke en tant que directeur le 23 août 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    43 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Vincent Hughes en tant que directeur le 25 juin 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Morley en tant que directeur le 25 juin 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    31 pagesAA

    Cessation de la nomination de Raj Bhogaita en tant que directeur le 15 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Kyle Anthony Burke en tant qu'administrateur le 09 juin 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Edward Stanton en tant qu'administrateur le 01 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KERSHAW, Keith
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Secrétaire
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    British74641230001
    BURKE, Kyle Anthony
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Administrateur
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish219136290001
    KERSHAW, Keith
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Administrateur
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish74641230001
    STANTON, Edward
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Administrateur
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish266217010001
    FARROW, Richard Kneen
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    Secrétaire
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    British84435750001
    KERSHAW, Keith
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    Secrétaire
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    British74641230001
    KERSHAW, Keith
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    Secrétaire
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    British74641230001
    LEE, David
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    Secrétaire
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    British77825310004
    WILD, Pamela Jayne
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    British64167100001
    WINTER, David John
    20 Orchard Road
    SG8 5HA Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Orchard Road
    SG8 5HA Royston
    Hertfordshire
    British109020270001
    APPLETON, Nigel John
    No 3 'Fetherson'
    Westfield Close
    RG26 3YG Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    No 3 'Fetherson'
    Westfield Close
    RG26 3YG Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritish127939110001
    BHOGAITA, Rajesh Prabhashanker
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    Administrateur
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    EnglandBritish206731300001
    BRUCE, Peter
    26 Longcroft Lane
    SK8 6SE Cheadle Hulme
    Cheshire
    Administrateur
    26 Longcroft Lane
    SK8 6SE Cheadle Hulme
    Cheshire
    United KingdomBritish112684140001
    BURKE, Anthony
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish58500120002
    BURKE, Anthony
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    British58500120001
    CAMPBELL, William John
    45 Shevington Lane
    Shevington
    WN6 8BH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    45 Shevington Lane
    Shevington
    WN6 8BH Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish38893410001
    CLARKE, Ian Herbert
    15 Wrenswood Drive
    Ellen Brook
    M28 7GS Worsley
    Manchester
    Administrateur
    15 Wrenswood Drive
    Ellen Brook
    M28 7GS Worsley
    Manchester
    British78560660001
    FARROW, Richard Kneen
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    Administrateur
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    British84435750001
    FIRTH, Christopher Roger
    5 Wellhouse Close
    Wigston
    LE18 2RQ Leicester
    Administrateur
    5 Wellhouse Close
    Wigston
    LE18 2RQ Leicester
    British84838310001
    FJODOR, Albert
    30 Salt Meadows
    CW5 5HF Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    30 Salt Meadows
    CW5 5HF Nantwich
    Cheshire
    British61168380002
    HAWKES, Timothy Charles
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    WalesBritish109021220001
    HODGE, Nicholas Edwin
    5 Westgate Park
    Hough
    CW2 5GY Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    5 Westgate Park
    Hough
    CW2 5GY Crewe
    Cheshire
    British78125710001
    HOLLOWS, Darren Mark
    53 Tamworth Road
    YO30 5GJ York
    North Yorkshire
    Administrateur
    53 Tamworth Road
    YO30 5GJ York
    North Yorkshire
    British78365860002
    HUGHES, Vincent
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish112684210001
    KERSHAW, Keith
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    Administrateur
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    EnglandBritish74641230001
    LEE, David
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    Administrateur
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    British77825310004
    LOGAN, Stuart
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    Administrateur
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    British112676540001
    LOGAN, Stuart
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    Administrateur
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    British112676540001
    MCGUIRE, John James
    5 Willowtree Close
    Whitley
    WN1 2LT Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    5 Willowtree Close
    Whitley
    WN1 2LT Wigan
    Lancashire
    British39572050002
    MCLOUGHLIN, Paul
    23 Sherbourne Drive
    Branston
    DE14 3GE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    23 Sherbourne Drive
    Branston
    DE14 3GE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish121582960001
    MORLEY, Andrew
    8 Dunn Brigg
    NG19 9RL Mansfield Woodhouse
    Nottinghamshire
    Administrateur
    8 Dunn Brigg
    NG19 9RL Mansfield Woodhouse
    Nottinghamshire
    EnglandBritish109020140001
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish90170480001
    REED, Graeme John
    5 Woodhall Croft
    B92 8TP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    5 Woodhall Croft
    B92 8TP Solihull
    West Midlands
    British38899010002
    SAYERS, Steven
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    Administrateur
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    United KingdomBritish91113050001
    SCARLETT, Alistair
    Drum Cabaig
    Dervaig Tobermory
    PA75 6QR Isle Of Mull
    Argyll
    Administrateur
    Drum Cabaig
    Dervaig Tobermory
    PA75 6QR Isle Of Mull
    Argyll
    British88554460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AVONSIDE ROOFING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Avonside Group Services Limited
    The Courtyard, Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    England
    15 juil. 2016
    The Courtyard, Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies House Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement6591179
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    AVONSIDE ROOFING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 oct. 2015
    Livré le 19 nov. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Timothy Hawkes
    Transactions
    • 19 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 févr. 2015
    Livré le 18 févr. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 juil. 2013
    Livré le 31 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Transactions
    • 31 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 13 nov. 2012
    Livré le 22 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The receivables meaning the debts and the payments instruments and all money, including without limitation, payments for work done and goods supplied see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Transactions
    • 22 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed & floating charge
    Créé le 30 juin 2008
    Livré le 09 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Andrew Morley
    Transactions
    • 09 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 31 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed & floating charge
    Créé le 30 juin 2008
    Livré le 09 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Timothy Charles Hawkes
    Transactions
    • 09 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 31 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed & floating charge
    Créé le 30 juin 2008
    Livré le 09 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Winter
    Transactions
    • 09 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed & floating charge
    Créé le 30 juin 2008
    Livré le 09 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Keith Kershaw
    Transactions
    • 09 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 31 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed & floating charge
    Créé le 30 juin 2008
    Livré le 09 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anthony Burke
    Transactions
    • 09 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 31 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 mars 2006
    Livré le 11 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,045.30 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    All interest in the deposit account and all money from time to time in accordance with the rent deposit deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Montague Albermarle Bertie
    Transactions
    • 11 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 nov. 2005
    Livré le 16 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anthony Burke and Keith Kershaw
    Transactions
    • 16 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 24 sept. 2003
    Livré le 15 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Commercial Services Limited
    Transactions
    • 15 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 24 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Natwest Factors Limited
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 05 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 12 juin 1989
    Livré le 20 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book debts and other debts floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital (excluding those mentioned above).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AVONSIDE ROOFING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 sept. 2022Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0