WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED

WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02333709
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WIMGROVE INVESTMENTS 1989 LIMITED29 mars 198929 mars 1989
    ABERCONWAY PROPERTIES LIMITED10 janv. 198910 janv. 1989

    Quels sont les derniers comptes de WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de * Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR* le 08 oct. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 janv. 2013

    État du capital au 24 janv. 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de David Edward Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Karen Atterbury en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Michael Andrew Lonnon en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Boynes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Karen Lorraine Atterbury le 28 mars 2011

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 80 New Bond Street London W1S 1SB* le 01 avr. 2011

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Colin Richard Clapham le 28 mars 2011

    2 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2 Piries Place Horsham West Sussex RH12 1EH England

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Karen Lorraine Atterbury le 30 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Colin Richard Clapham le 11 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147316690001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34521340004
    SMITH, David Edward
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritish267619370001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British175715660001
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Secrétaire
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    British32824200005
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Secrétaire
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    British32824200005
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    LEVEN, Steven
    69 Northolt Road
    HA2 0LP South Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    69 Northolt Road
    HA2 0LP South Harrow
    Middlesex
    British37605240001
    WHEATLEY, Catherine Bernadette
    138 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NL London
    Secrétaire
    138 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NL London
    British47834500001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish175715660001
    BIRD, Michael Thomas
    115 Crabtree Lane
    AL5 5RQ Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    115 Crabtree Lane
    AL5 5RQ Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish437220001
    BOYNES, Martin Geoffrey
    Leith Wood Cottage
    Abinger Common
    RH5 6LP Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Leith Wood Cottage
    Abinger Common
    RH5 6LP Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish39925150002
    GARROD, Douglas Victor
    Westmorland House
    Station Road
    RG17 9UP Kintbury
    Berkshire
    Administrateur
    Westmorland House
    Station Road
    RG17 9UP Kintbury
    Berkshire
    EnglandBritish104783210001
    LAVERS, Michael John
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    Administrateur
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    EnglandBritish3090450001
    LEYLAND, Anthony Edward
    32 Birchwood Road
    Petts Wood
    BR5 1NZ Bromley
    Kent
    Administrateur
    32 Birchwood Road
    Petts Wood
    BR5 1NZ Bromley
    Kent
    British36120880001
    MOORE, Henry William
    37 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    Administrateur
    37 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    British2896620001
    WAGHORN, Richard Seymour
    2 High Garth
    KT10 9DN Esher
    Surrey
    Administrateur
    2 High Garth
    KT10 9DN Esher
    Surrey
    United KingdomBritish50505200001
    WISEMAN, Shalom David
    2 Woodville Gardens
    Ealing
    W5 2LG London
    Administrateur
    2 Woodville Gardens
    Ealing
    W5 2LG London
    British32990150001

    WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed supplemental to a mortgage debenture
    Créé le 04 sept. 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement dated 23/08/89 (as defined in the charge) supplemental to a mortgage debenture dated 16/08/91
    Brèves mentions
    All of the company's rights and benefitsunder the relevant agreements see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited,as Agent and Trustee for the Banks and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed supplemental to a mortgage debenture
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement dated 23/08/89 (as defined in the charge) supplemental to a mortgage debenture dated 16/08/91
    Brèves mentions
    All of the company's rights and benefitsunder the relevant agreement see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited,as Agent and Trustee for the Banks and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed supplemental to a mortgage debenture
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement dated 23/08/89 (as defined in the charge) supplemental to a mortgage debenture dated 16/08/91
    Brèves mentions
    All of the company's rights and benefitsunder the relevant agreement see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited,as Agent and Trustee for the Banks and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed supplemental to a mortgage debenture
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement dated 23/08/89 (as defined in the charge) supplemental to a mortgage debenture dated 16/08/91
    Brèves mentions
    All of the company's rights and benefitsunder the relevant agreement see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited,as Agent and Trustee for the Banks and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed supplemental to a mortgage debenture
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement dated 23/08/89 (as defined in the charge) supplemental to a mortgage debenture dated 16/08/91
    Brèves mentions
    All the company's rights and benefits under the relevant agreement see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited,as Agent and Trustee for the Banks and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed supplemental to a mortgage debenture
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement dated 23/08/89 (as defined in the charge) supplemental to a mortgage debenture dated 16/08/91
    Brèves mentions
    L/H property k/as little britain in the city of london together with buildings and fixtures the proceeds of sale thereof fixed charge over plant and machinery the benefit of all licences see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited,as Agent and Trustee for the Banks and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 août 1991
    Livré le 06 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to(a) natwest investment bank limited as agent and trustee for the banks as defined, and each of them under the loan agreement or any other security document (as defined) and (b) national westminster bank PLC as overdraft bank under the overdraft facility letter (as defined)
    Brèves mentions
    (Please see M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transactions
    • 06 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WIMPEY LITTLE BRITAIN (NO.2) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 mai 2014Dissolved on
    24 sept. 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0