ALLDERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALLDERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02338866
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALLDERS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe ALLDERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Kroll
    10 Fleet Palce
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALLDERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALLDERS PLC15 mai 198915 mai 1989
    HAWKMAC LIMITED25 janv. 198925 janv. 1989

    Quels sont les derniers comptes de ALLDERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 juin 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour ALLDERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    7 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2013

    10 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 mars 2013

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2012

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 mars 2012

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 mars 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2010

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 mars 2010

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2009

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 mars 2009

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 sept. 2008

    5 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:miscellaneous :-s/s/ cert. "Release of liquidator"
    1 pagesLIQ MISC

    Divers

    C/O replacement of liquidator
    4 pagesMISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    12 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    12 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.24B

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de ALLDERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHARD, Caroline Rosemary
    7 Carlisle Close
    KT2 7AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    7 Carlisle Close
    KT2 7AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British34030360001
    PRIDEAUX, Robert David
    Staddles
    Romsey Road
    SO51 6EB Wellow
    Hampshire
    Secrétaire
    Staddles
    Romsey Road
    SO51 6EB Wellow
    Hampshire
    British258430004
    SHARPE, Emma Jane
    160 Westhill
    Putney
    SW15 3SR London
    Secrétaire
    160 Westhill
    Putney
    SW15 3SR London
    British102536710001
    SMITH, Stephen Hugh
    13 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    Secrétaire
    13 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    British78228180002
    ADAMS, Michael Percy
    41 Broad Oaks Road
    B91 1JA Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    41 Broad Oaks Road
    B91 1JA Solihull
    West Midlands
    British325700001
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Hawthorn Hill
    Warfield
    RG42 6HE Bracknell
    Tudor Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hawthorn Hill
    Warfield
    RG42 6HE Bracknell
    Tudor Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134262810001
    BARTON, Eric Anthony
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish1323220001
    BLAKEMORE, James Corry
    42 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Administrateur
    42 Clarendon Road
    W11 3AD London
    American86416170001
    BROOKS, Paul
    20 Marlin House
    22 St Johns Avenue
    SW15 2AA London
    Administrateur
    20 Marlin House
    22 St Johns Avenue
    SW15 2AA London
    British44858240001
    COLLYER, Anthony David
    Camel Farm Cottage
    Queen Camel
    BA22 7NB Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    Camel Farm Cottage
    Queen Camel
    BA22 7NB Yeovil
    Somerset
    British49685240001
    COX, Philip Robert
    Stone Garth
    Crowhill Lane
    HG3 2LG High Birstwith
    North Yorkshire
    Administrateur
    Stone Garth
    Crowhill Lane
    HG3 2LG High Birstwith
    North Yorkshire
    British58419290005
    FIDLER, Brian Harvey
    The Eighth House Vernon Avenue
    OX2 9AU Oxford
    Administrateur
    The Eighth House Vernon Avenue
    OX2 9AU Oxford
    EnglandBritish57282470001
    GARRARD, David Eardley, Sir
    42 Wigmore Street
    W1U 2RY London
    Administrateur
    42 Wigmore Street
    W1U 2RY London
    British76373440003
    GREEN, Terrance Anthony
    Flat 10
    224 Great Portland Street
    W1W 5AA London
    Administrateur
    Flat 10
    224 Great Portland Street
    W1W 5AA London
    British106751550001
    IVEY, Rodney Guy
    Farm House 34 The Avenue
    KT20 5AT Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Farm House 34 The Avenue
    KT20 5AT Tadworth
    Surrey
    British10867780003
    JOHARI, Aaron Omar
    2 Church Farm Way
    WD25 8BD Aldenham
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Church Farm Way
    WD25 8BD Aldenham
    Hertfordshire
    British78627650001
    KAUFMAN, Stan Joel
    Grey Barn Hill Hoath Road
    Chiddingstone
    TN8 7AE Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Grey Barn Hill Hoath Road
    Chiddingstone
    TN8 7AE Edenbridge
    Kent
    EnglandBritish148943570001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Administrateur
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LEE, Wilson Yao Chang
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    Administrateur
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    American52557130001
    LIPSITH, Harvey Brian
    Heronsmore 4 Martello Road
    Canford Cliffs
    BH13 7DH Poole
    Dorset
    Administrateur
    Heronsmore 4 Martello Road
    Canford Cliffs
    BH13 7DH Poole
    Dorset
    British425860001
    MERCER, Trevor David
    Thatched Cottage
    Woodlea Way
    SO51 9DA Ampfield
    Hampshire
    Administrateur
    Thatched Cottage
    Woodlea Way
    SO51 9DA Ampfield
    Hampshire
    British3095080001
    O'CATHAIN, Detta, Baroness
    C129 Parliament View Apartments
    1 Albert Embankment
    SE1 7XN London
    Administrateur
    C129 Parliament View Apartments
    1 Albert Embankment
    SE1 7XN London
    British45510340002
    PATTISSON, John Harmer
    1c Elm Place
    SW7 3QH London
    Administrateur
    1c Elm Place
    SW7 3QH London
    British23743570001
    PETTIT, Andrew John
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    Administrateur
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    British62947400001
    PRIOR, James Michael Leathes, The Rt Hon Lord
    Old Hall
    Brampton
    NR34 Beccles
    Suffolk
    Administrateur
    Old Hall
    Brampton
    NR34 Beccles
    Suffolk
    British45046180001
    RIXON, Arthur John
    Little Sweethaws Sweethaws
    TN6 3SS Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    Little Sweethaws Sweethaws
    TN6 3SS Crowborough
    East Sussex
    British40591390001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Administrateur
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritish118467060001
    SHERRATT, Peter Robert
    Ark End Mallows Green Road
    Manuden
    CM23 1BP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Ark End Mallows Green Road
    Manuden
    CM23 1BP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British34368510002
    SLAYMAKER, Peter Alan
    The Laurels Clifton Road
    BH14 9PP Poole
    Dorset
    Administrateur
    The Laurels Clifton Road
    BH14 9PP Poole
    Dorset
    British63164360001
    TAGUE, Stephen Paul
    Tagair 69 Burkes Road
    HP9 1PW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Tagair 69 Burkes Road
    HP9 1PW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70977900002
    THOMAS, Barbara, Lady
    St James's Street
    SW1A 1HD London
    33
    Administrateur
    St James's Street
    SW1A 1HD London
    33
    American88709030001
    TUCKEY, James Lane
    95 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    Administrateur
    95 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    United KingdomBritish35019240001
    WEBSTER, Catherine Helen
    26 Princes Road
    TW10 6DH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    26 Princes Road
    TW10 6DH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish95183960001

    ALLDERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 nov. 2004
    Livré le 09 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become from any of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 juin 2004
    Livré le 08 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited (As Security Trustee for the Senior Finance Parties)
    Transactions
    • 08 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 16 mars 2004
    Livré le 26 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Other than the f/h and l/h property k/a allders department store croydon t/nos SGL531870, SGL531871,SGL531873, SGL114390, SY152523, SGL114391, SY195965 and SGL616403. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2004
    Livré le 26 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The properties being f/h high street, bromley kent t/n K120262, f/h high street obelisk street and london road camberley surrey t/n SY315131,SY421656,ST317034,ST245962,SY689978,SY222428,SY453342, SY683569, SY552443. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited
    Transactions
    • 26 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2003
    Livré le 10 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Bromley - high street bromley kent BR1 1HJ freehold:K120262 (absolute), clapham junction - arding & hobbs lavender hill st johns road and illminster gardens london SW11 1QL freehold 411802 (absolute), coventry - allders department store broadgate shopping centre coventry CV1 1NA long leasehold WM641517 (absolute) (please refer to the form 395 for futher properties charged). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Danske Bank a/S
    Transactions
    • 10 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2003
    Livré le 10 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Bromley - high street bromley kent BR1 1HJ freehold:K120262 (absolute), clapham junction - arding & hobbs lavender hillm st johns road and illminster gardens london SW11 1QL freehold 411802 (absolute), coventry - allders department store broadgate shopping centre coventry CV1 1NA long leasehold WM641517 (absolute) (please refer to the form 395 for futher properties charged). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2003
    Livré le 08 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 08 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mai 1992
    Livré le 12 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the banks under the terms of a debenture dated 15/5/89
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 5 aylesford retail park london rd, aylesford kent with fixtures & fittings (inc trade) t/no K691604.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 12 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mai 1992
    Livré le 12 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 15/5/89
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 2 the greyhound park sealand rd, chester cheshire with fixtures & fittings (inc trade) t/no ch 293791.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 12 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 août 1991
    Livré le 30 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the escrow agreement dated 23.8.91 and any other security documents (as defined in the deed).
    Brèves mentions
    First fixed charge over all sums now or hereafter deposited in account no:- 440000. at westpac banking corporation and all interest or other sums which may accrue from time to time thereon.
    Personnes ayant droit
    • Federal Airports Corporation
    Transactions
    • 30 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 19 oct. 1990
    Livré le 08 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as defined in the deed
    Brèves mentions
    See doc M183 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hanson PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1990
    Livré le 16 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 15/5/89
    Brèves mentions
    L/H property k/a part of the 6TH floor and two car parking spaces, royal london house, bournemouth & all buildings and fixtures (including trade).
    Personnes ayant droit
    • Hanson PLC
    Transactions
    • 16 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1990
    Livré le 16 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 15/5/89
    Brèves mentions
    L/H property k/a part of the 6TH floor and two car parking spaces, royal london house, bournemouth & all buildings and fixtures (including trade).
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 16 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 29 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1990
    Livré le 16 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 15/5/89
    Brèves mentions
    L/H property k/a part of the 6TH floor and two car parking spaces, royal london house, bournemouth & all buildings and fixtures (including trade).
    Personnes ayant droit
    • Hanson PLC
    Transactions
    • 16 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1990
    Livré le 16 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 15/5/89
    Brèves mentions
    L/H property k/a part of the 6TH floor and two car parking spaces, royal london house, bournemouth & all buildings and fixtures (including trade).
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 16 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 15 mai 1989
    Livré le 31 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee chemical bank as agent for the benefit of the banks as defined on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see mort doc 395-M322-for further details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 31 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 03 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 15 mai 1989
    Livré le 17 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,454.287 and all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the guarantee & debenture dated 15/5/89 and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hanson Plcas Trustee for the Benefit of the Stockholders
    Transactions
    • 17 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ALLDERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 sept. 2006Administration ended
    04 févr. 2005Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Andrew John Pepper
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DateType
    13 avr. 2014Dissolved on
    29 sept. 2006Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Andrew John Pepper
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Neil Hunter Cooper
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0