J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED

J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02339787
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    St Nicholas House Park Row
    NG1 6FQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2010

    10 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    8 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mai 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mai 2009

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2008

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    6 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    8 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Qui sont les dirigeants de J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOM, Colin
    28 Laureston Drive
    LE2 2AQ Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    28 Laureston Drive
    LE2 2AQ Leicester
    Leicestershire
    British72322870002
    POWNALL, David Michael
    The Old Chapel 35 Main Street
    Kinoulton
    NG12 3EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Old Chapel 35 Main Street
    Kinoulton
    NG12 3EA Nottingham
    Nottinghamshire
    British78687410002
    POWNALL, Michael
    2 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    2 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British9610500001
    BROWN, Christopher Frank
    16 Whatton Oaks
    Rothley
    LE7 7QE Leicester
    Secrétaire
    16 Whatton Oaks
    Rothley
    LE7 7QE Leicester
    British61859510001
    TURNER, Andrew Richard
    Rose Cottage Bleasby Road
    Thurgarton
    NG14 7FW Nottingham
    Secrétaire
    Rose Cottage Bleasby Road
    Thurgarton
    NG14 7FW Nottingham
    British74225120001
    SPALDING, Andrew
    Field House 2 Manor Court
    Willoughby On The Wolds
    LE12 6SS Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    Field House 2 Manor Court
    Willoughby On The Wolds
    LE12 6SS Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish43693090001
    WAINE, Paul
    35 Quayside Close
    NG2 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    35 Quayside Close
    NG2 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    British9756380001

    J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 mai 2000
    Livré le 01 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents or any other document
    Brèves mentions
    The property known as land on the north west side of harrimans lane, dunkirk t/no:288435 and the proceeds of sale thereof and all compensation or grants payable or paid to or recoverable by the mortgagor in respect of the property and all other estates and interests which the mortgagor may have in the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 01 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 19 mai 2000
    Livré le 01 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever whether incurred under the finance documents or any other documents (all as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 01 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2001Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 19 janv. 2006Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
    Mortgage
    Créé le 21 févr. 2000
    Livré le 23 févr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 20 august 19999 as varied by a novation agreement documented by an exchange of letters dated 10 january 2000 and 14 january 2000 and other monies due under this deed
    Brèves mentions
    All debts arising from the sale of aluminium deoxidants or other products supplied by the chargee to the company under the agreement.
    Personnes ayant droit
    • Tinfos Nizi S.A.
    Transactions
    • 23 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of certain debts
    Créé le 20 août 1999
    Livré le 27 août 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 20TH august 1999 and/or this mortgage
    Brèves mentions
    All debts arising from the sale of goods by the company to british stell pursuant to an agreement dated 20TH august 1999.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Compagnie Des Mines Et Metaux S.A.
    Transactions
    • 27 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 4 june 1990 issued by the company
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 07 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assignment of the items listed below (the equipment) including any part or parts thereof and all additional alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party; items: multi melting furnace.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 26 mars 1999
    Livré le 10 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due from nottingham metal recyclers limited to the chargees and intended to be secured by this mortgage including a loan by michael pownall (the first lender) of £200,000 ,a loan by michael pownall of £250,000 ,a loan by margaret annette pownall (the second lender) of £20,000 and any sums due under guarantees dated 10TH march 1999
    Brèves mentions
    The assignment by way of security of the schematic melting furnace with ancillary equipment located at alcester street dunkirk nottingham NG7 2SF and a floating charge over all other plant machinery furniture equipment and other tangible assets.
    Personnes ayant droit
    • Michael Pownall
    • Margaret Annette Pownall
    Transactions
    • 10 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of chattels
    Créé le 28 nov. 1995
    Livré le 28 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000,000 due from the company to the chargee pursuant to a master hire purchase agreement made the 27TH september 1995 and hiring contract made the 28TH november 1995
    Brèves mentions
    Schematic melting unit with ancillary equipment located at alcester street dunkirk nottingham NG7 2SF as more full described in the mortgage of chattels.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 oct. 1990
    Livré le 26 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Initial Leasing Limited
    Transactions
    • 26 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over contruct
    Créé le 26 sept. 1990
    Livré le 11 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All benefit of rebate of rentals payments from a leasing agreement.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 juin 1990
    Livré le 14 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 mai 2001Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gurpil Singh Johal
    Kroll Limited
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    practitioner
    Kroll Limited
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    Lee Antony Manning
    Aspect Court
    4 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    practitioner
    Aspect Court
    4 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    2
    DateType
    27 mai 2005Commencement of winding up
    05 avr. 2011Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Allan Watson Graham
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    practitioner
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    James Douglas Ernle Money
    Kpmg Llp
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    practitioner
    Kpmg Llp
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    practitioner
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0