BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02342138
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLOWPLUS PUBLIC LIMITED COMPANY 01 févr. 198901 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 juin 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 juin 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 juin 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,839,109.2
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,855,587.6
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,870,882.8
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,769,624.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,812,567.6
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,708,879.8
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 févr. 2026Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,759,258.8
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,528,110.6
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,602,245.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,661,384.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,183,305
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,402,725
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 4,487,538
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 3,980,226.6
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 3,724,733.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    15 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 3,525,708
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 3,325,995
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,980,231.2
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 3,145,392
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,834,196.6
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,433,291
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 oct. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,668,648.2
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 oct. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,209,913.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 oct. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2025

    279 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,994,849.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 oct. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Qui sont les dirigeants de BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BORRETT, Nicholas James William
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    206640400001
    CAIRNIE, Linda Ruth
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish151895420001
    COMISKEY, Aedamar Ita, Dr
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandIrish340085790001
    FORSTER, Carl-Peter Edmund Moriz
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    GermanyGerman270243680001
    LOCKWOOD, David Charles
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish275116030001
    MELLORS, David Anthony
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish280091100001
    MORIARTY, Jane Bronwen
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandIrish302907590001
    NATANSON, Claudia Carmelita
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish320049740001
    PARKER, Andrew David, Sir
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish280090900001
    RAMSAY, John
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    ScotlandBritish291399800001
    SMITH, Kevin, Sir
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish309680080001
    ALLEN, John
    "Wychwood" Liphook Road
    Whitehill
    GU35 9DA Bordon
    Hampshire
    Secrétaire
    "Wychwood" Liphook Road
    Whitehill
    GU35 9DA Bordon
    Hampshire
    British46969370001
    DUNGATE, Albert Norman
    c/o Babcock International Group Plc
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Secrétaire
    c/o Babcock International Group Plc
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    British160565590001
    MAHY, Helen Margaret
    Cloche Merle Merle Common Road
    Merle Common
    RH8 0RP Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    Cloche Merle Merle Common Road
    Merle Common
    RH8 0RP Oxted
    Surrey
    British40686780001
    BETHEL, Archibald Anderson
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    ScotlandBritish47190540010
    CAMPBELL, Gordon Arden
    Green Meadow House
    Green Lane
    RG8 7BG Pangbourne
    Berkshire
    Administrateur
    Green Meadow House
    Green Lane
    RG8 7BG Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritish14980740002
    CROOKENDEN, Justin Nicholas Aidan
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    British39698730002
    DAVIES, John Richard
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United KingdomBritish128289970002
    DIMES, Lucy Rebecca
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United KingdomBritish155717720003
    DUNCAN, Ian Barnet
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United KingdomBritish155565020002
    EASTON, Murray Simpson
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    Administrateur
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    British52962730001
    ESSENHIGH, Nigel Richard, Sir
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    British89206710003
    GIBB, Francis Ross, Sir
    11 Latchmoor Avenue
    SL9 8LJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    11 Latchmoor Avenue
    SL9 8LJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British677420001
    HARTIGAN, Ian Guy Stewart
    The Gate House Guildford Lodge Drive
    KT24 6RJ East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    The Gate House Guildford Lodge Drive
    KT24 6RJ East Horsley
    Surrey
    British10487320001
    HESKETH, Thomas Alexander, Lord
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    British40855800003
    HOULDEN, John Russell
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish272738560001
    KING OF WARTNABY, John Leonard, The Lord
    Friars Well
    Wartnaby
    L14 3HY Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Friars Well
    Wartnaby
    L14 3HY Melton Mowbray
    Leicestershire
    British30236640002
    LACE, John Herbert
    Brackenhurst
    13 Symington Road North
    KA1 5PZ Symington
    Ayrshire
    Administrateur
    Brackenhurst
    13 Symington Road North
    KA1 5PZ Symington
    Ayrshire
    British4661440001
    LEE, Myles Peter
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    IrelandIrish196398810001
    MARGERIE, Victoire Anne Marie De, Professor
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    England
    FranceFrench204699580001
    MARTINELLI, Franco
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish85507440001
    OMAND, David Bruce, Sir
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandBritish67152590002
    PARKER, Thomas John, Sir
    Apt 29 Westfield
    15 Kidderpore Avenue
    NW3 7SF Hampstead London
    Administrateur
    Apt 29 Westfield
    15 Kidderpore Avenue
    NW3 7SF Hampstead London
    Great BritainBritish76722560001
    PORTER, Erik Alexander Steven
    20 The Mall
    East Sheen
    SW14 7EN London
    Administrateur
    20 The Mall
    East Sheen
    SW14 7EN London
    British10560001
    RANDALL, Jeff William
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United KingdomBritish41481480001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0