CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED

CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02344588
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bunbury House
    Stour Park
    DT11 9LQ Blandford Forum
    Dorset
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CMS DEVELOPMENTS LIMITED04 avr. 198904 avr. 1989
    GREATFAWN ESTATES LIMITED07 févr. 198907 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 02 août 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2010

    8 pagesAA

    legacy

    4 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 janv. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 janv. 2008

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cms developments LIMITED\certificate issued on 14/12/06
    2 pagesCERTNM

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2004

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LANG, David Maries
    6 Cornwall Road
    DT1 1RT Dorchester
    Dorset
    Secrétaire
    6 Cornwall Road
    DT1 1RT Dorchester
    Dorset
    British22288880003
    ALDRED, Neil Anthony
    7 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    7 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishDirector39617270002
    BUCKLES, Peter Alexander
    Cheriton House
    74 Gregories Road
    HP9 1HL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cheriton House
    74 Gregories Road
    HP9 1HL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector45671630005
    NIELSEN, Phillip John
    Style Cottage Pitts Lane
    Bishopstone
    SP5 4DQ Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Style Cottage Pitts Lane
    Bishopstone
    SP5 4DQ Salisbury
    Wiltshire
    British22844680001
    NIELSEN, Phillip John
    Style Cottage Pitts Lane
    Bishopstone
    SP5 4DQ Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Style Cottage Pitts Lane
    Bishopstone
    SP5 4DQ Salisbury
    Wiltshire
    BritishAccountant22844680001

    CMS DEVELOPMENTS (2006) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings being units 1-2 southport way business park old sarum laverstock also k/a units 1 and 2 danebury court old sarum business park salisbury t/no. WT179738 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the east side of eastern road aldershot also k/a units 1-4 kingston industrial estate eastern road aldershot t/no. HP411046 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 13 févr. 2001
    Livré le 17 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a units 3 & 4 old sarum park (otherwise k/a south portway business park) old sarum laverstock salisbury in wiltshire) (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 17 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 07 août 1992
    Livré le 11 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over the l/h property k/a units 1 - 11 black water industrial estate, black water way, aldershot, hampshire title no. HP373249 floating charge over all the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Nykredit Mortgage Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 25 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 1, 2 and 3 daux road, billingshurst, west sussex together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1991
    Livré le 05 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property on the east side of eastern road aldershot, hampshire all buildings, structures fixtures & fittings floating charge over the undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Nykredit Mortgage Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juin 1990
    Livré le 19 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a luvisca factory at railway street taunton, somerset together with all fixed machinery buildings erections other fixtures & fittings erected on or affixed to the property by way of floating charge the undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • The National Mortgage Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 juin 1990
    Livré le 19 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The National Mortgage Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 20 juin 1989
    Livré le 28 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H plot of land together with the buildings thereon k/a 54 hewitt street, knott mill, manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0