TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED

TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02345011
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASHURST PARK INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED23 janv. 199123 janv. 1991
    SCATSOUTH A51 LIMITED08 févr. 198908 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Simon Gordon en tant que directeur le 02 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Spire Healthcare Limited en tant qu'administrateur le 02 nov. 2015

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Robert Roger en tant que directeur le 02 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Gordon le 01 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Roger le 01 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Roger le 01 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Gordon le 01 juil. 2015

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom à 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2015

    État du capital au 09 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 févr. 2014

    État du capital au 11 févr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * 120 Holborn London EC1N 2TD* le 12 déc. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daniel Francis Toner le 23 août 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Jean De Gorter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Secrétaire
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    British100270040001
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Administrateur
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish100270040002
    SPIRE HEALTHCARE LIMITED
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1522532
    202359590001
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    PRESTON, David James
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    British46551430003
    PRESTON, David James
    5 Cock Robin Cottages
    Croston
    PR5 7HH Preston
    Secrétaire
    5 Cock Robin Cottages
    Croston
    PR5 7HH Preston
    British46551430001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Secrétaire
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Secrétaire
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BARKER, Hilary Jane
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    Administrateur
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    British62838010001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105797560001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    CHADWICK, Bernard Keith
    Willow Glen Dowbridge
    Kirkham
    PR4 2YL Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Willow Glen Dowbridge
    Kirkham
    PR4 2YL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish3632310001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DE GORTER, Jean Jacques, Dr
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomFrench128865640001
    DUGDALE, Michael Ian
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    Administrateur
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    British79570840001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    FOZARD, Ian
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish21934910001
    GORDON, Simon
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Administrateur
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish162037020001
    GRAY, Duncan Archibald
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    Administrateur
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    EnglandBritish68845270002
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Administrateur
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Administrateur
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British84030950001
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    British32671980002
    HOLLINGSWORTH, Clare Margaret
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    Administrateur
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    United KingdomBritish62952630002
    JONES, Richard James Edward
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    EnglandBritish133019680001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Administrateur
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Raymond
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    British56146040001
    LEA, Edward William
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    British28018450003
    PRESTON, David James
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    Administrateur
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    British46551430003
    ROGER, Robert
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Administrateur
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish151959030001
    SARSFIELD, Vincent Gerard
    Little Lowes Fold Heath Lane
    Lowton
    WA3 2SJ Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Little Lowes Fold Heath Lane
    Lowton
    WA3 2SJ Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish5491860001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security accession deed
    Créé le 22 oct. 2008
    Livré le 29 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 29 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 2002
    Livré le 31 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Borrower Security Trustee (as Defined Therein)
    Transactions
    • 31 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juil. 1996
    Livré le 20 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K709645 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 25 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 25 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 déc. 1991
    Livré le 08 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts andthe benefits of any licences l/h property comprised in title no k 709645 being a lease of ashurst park independent hospital fordcombe road tunbridge wells kent from ibh limited (1) to ashurst park independent hospital limited (2) dated 21/8/91.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 21 août 1991
    Livré le 10 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage l/h property, tunbridge wells independent hospital tunbridge wells kent. Including all fixtures fittings other than trade fixtures and fittings plant and machinery. (See form 395 and continuation sheet for full details document M114). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juil. 1991
    Livré le 09 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account
    Brèves mentions
    (See for 395 document M13C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 janv. 1991
    Livré le 24 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    500000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of charge.
    Brèves mentions
    Land at ashurst park fordcombe county of kent being part of land comprised in t/no. K535622.
    Personnes ayant droit
    • Ibh Limited.
    Transactions
    • 24 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 1990
    Livré le 31 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at ashurst park near fordcombe road, fordcombe in the company of kent title no K535622. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0