SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED

SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSECURITY CENTRES SECURUS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02345265
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ruby Court (No.9-18) Wesley Drive
    Benton Square Industrial Estate
    NE12 9UP Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SECURITY CENTRES (G.B.) LIMITED28 févr. 198928 févr. 1989
    NOVABURN LIMITED09 févr. 198909 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de John Stewart en tant que directeur le 05 mars 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Kanga 2020 Limited en tant qu'administrateur le 06 févr. 2020

    2 pagesAP02

    Nomination de Securus Group Limited en tant qu'administrateur le 06 févr. 2020

    2 pagesAP02

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    13 pagesAA

    legacy

    41 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2018

    18 pagesAA

    legacy

    38 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Cessation de la nomination de Anthony Denis Kane en tant que directeur le 19 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 023452650018, créée le 20 déc. 2018

    73 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de The Securus Group, Suite 506, Chadwick House Warrington Road Birchwood Park, Birchwood Warrington WA3 6AE England à Ruby Court (No.9-18) Wesley Drive Benton Square Industrial Estate Newcastle upon Tyne NE12 9UP le 25 juil. 2018

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Grant Gordon Davidson en tant que directeur le 31 mars 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de Muzinich Uk Private Debt Sarl en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mai 2018

    1 pagesPSC07

    Notification de Securus Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 nov. 2016

    2 pagesPSC02

    Inscription de la charge 023452650017, créée le 16 avr. 2018

    73 pagesMR01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 mars 2018

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KANGA 2020 LIMITED
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    5th Floor
    London
    England
    Administrateur
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    5th Floor
    London
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement12417677
    266965660001
    SECURUS GROUP LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    England
    Administrateur
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement10489886
    266969200001
    PHILLIPS, Simon John
    4 The Gables
    Three Crosses
    SA4 3PL Swansea
    West Glamorgan
    Secrétaire
    4 The Gables
    Three Crosses
    SA4 3PL Swansea
    West Glamorgan
    British57949100004
    CARTER, Anne Mary
    Southglade Business Park
    Top Valley
    NG5 9RA Nottingham
    Unit E1 Cowlairs
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Southglade Business Park
    Top Valley
    NG5 9RA Nottingham
    Unit E1 Cowlairs
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritishCommercial Director174443780001
    DAVIDSON, Grant Gordon
    Warrington Road
    Birchwood Park, Birchwood
    WA3 6AE Warrington
    The Securus Group, Suite 506, Chadwick House
    England
    Administrateur
    Warrington Road
    Birchwood Park, Birchwood
    WA3 6AE Warrington
    The Securus Group, Suite 506, Chadwick House
    England
    United KingdomBritishInvestment Professional218970320001
    DAVIS, Simon Henry
    Albert Square
    M2 5PE Manchester
    16-18
    England
    Administrateur
    Albert Square
    M2 5PE Manchester
    16-18
    England
    United KingdomBritishDirector32324700004
    GLOVER, Stuart
    Southglade Business Park
    Top Valley
    NG5 9RA Nottingham
    Unit E1 Cowlairs
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Southglade Business Park
    Top Valley
    NG5 9RA Nottingham
    Unit E1 Cowlairs
    Nottinghamshire
    England
    ScotlandBritishCompany Director114721630001
    HOLDER, Jeff James
    73 - 79 King Street
    M2 4NG Manchester
    The Pinnacle
    England
    Administrateur
    73 - 79 King Street
    M2 4NG Manchester
    The Pinnacle
    England
    United KingdomBritishDirector239215580001
    KANE, Anthony Denis
    Wesley Drive
    Benton Square Industrial Estate
    NE12 9UP Newcastle Upon Tyne
    Ruby Court (No.9-18)
    United Kingdom
    Administrateur
    Wesley Drive
    Benton Square Industrial Estate
    NE12 9UP Newcastle Upon Tyne
    Ruby Court (No.9-18)
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector189809150001
    PHILLIPS, Simon John
    Kingsway
    Fforestfach
    SA5 4DL Swansea
    Portcullis House
    Wales
    Administrateur
    Kingsway
    Fforestfach
    SA5 4DL Swansea
    Portcullis House
    Wales
    WalesBritishSecurity Engineer57949100004
    REES, Graham
    Morriston
    SA6 6PD Swansea
    24 Cwm Gelli Road
    Wales
    Administrateur
    Morriston
    SA6 6PD Swansea
    24 Cwm Gelli Road
    Wales
    WalesWelshSecurity Engineer41318510004
    SHIRMAN, Marc David
    Southglade Business Park
    Top Valley
    NG5 9RA Nottingham
    Unit E1 Cowlairs
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Southglade Business Park
    Top Valley
    NG5 9RA Nottingham
    Unit E1 Cowlairs
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritishFinance Director165571770002
    STEWART, John
    Wesley Drive
    Benton Square Industrial Estate
    NE12 9UP Newcastle Upon Tyne
    Ruby Court (No.9-18)
    United Kingdom
    Administrateur
    Wesley Drive
    Benton Square Industrial Estate
    NE12 9UP Newcastle Upon Tyne
    Ruby Court (No.9-18)
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director157847140001
    VICKERS, Philip
    16-18
    Albert Square
    M2 5PE Manchester
    Carlton House
    England
    Administrateur
    16-18
    Albert Square
    M2 5PE Manchester
    Carlton House
    England
    EnglandBritishAccountant39881280001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Muzinich Uk Private Debt Sarl
    King Street
    M2 4NG Manchester
    The Pinnacle
    England
    30 nov. 2016
    King Street
    M2 4NG Manchester
    The Pinnacle
    England
    Oui
    Forme juridiqueSarl
    Pays d'enregistrementLuxembourg
    Autorité légaleLuxembourg
    Lieu d'enregistrementLuxembourg
    Numéro d'enregistrementB 203427
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Securus Group Limited
    Warrington Road
    Birchwood
    WA3 6AE Warrington
    Suite 506 Chadwick House
    England
    21 nov. 2016
    Warrington Road
    Birchwood
    WA3 6AE Warrington
    Suite 506 Chadwick House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies (England & Wales)
    Numéro d'enregistrement10489886
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SECURITY CENTRES SECURUS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 déc. 2018
    Livré le 21 déc. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich UK Private Debt S.a R.L. (As Lender)
    • Muzinich North West Private Debt S.a R.L. (As Lender)
    Transactions
    • 21 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 16 avr. 2018
    Livré le 26 avr. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich UK Private Debt S.a R.L.
    • Muzinich North West Private Debt S.a R.L.
    Transactions
    • 26 avr. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 nov. 2017
    Livré le 13 nov. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich North West Private Debt S.A.R.L.
    • Muzinich UK Private Debt S.A.R.L.
    Transactions
    • 13 nov. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 août 2017
    Livré le 01 sept. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich North West Private Debt S.a R.L.
    • Muzinich UK Private Debt S.a R.L.
    Transactions
    • 01 sept. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2017
    Livré le 30 juin 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich North West Private Debt S.A.R.L.
    • Muzinich UK Private Debt S.A.R.L.
    Transactions
    • 30 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 mai 2017
    Livré le 19 mai 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich North West Private Debt S.A.R.L,
    • Muzinich UK Private Debt S.A.R.L.
    Transactions
    • 19 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 04 mai 2017
    Livré le 19 mai 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich North West Private Debt S.a R.L.
    • Muzinich UK Private Debt S.a R.L.
    Transactions
    • 19 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 déc. 2016
    Livré le 16 déc. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Muzinich North West Private Debt S.a R.L.
    • Muzinich UK Private Debt S.a R.L.
    Transactions
    • 16 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 07 oct. 2016
    Livré le 12 oct. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    No specific land, ship, aircraft or intellectual property has been charged by the company. For full details of the charges, please refer to the charge document.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 févr. 2016
    Livré le 16 févr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 16 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 juil. 2014
    Livré le 07 juil. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    1. all land vested in or charged to security centres (G.B.) limited, all fixtures and fittings attached to that land and all rents receivable from any lease granted out of that land. References to land are to any interest in heritable, freehold or leasehold land.. 2. all the goodwill of security centres (G.B.) limited’s business.. 3. all intellectual property, licences, claims, insurance policies, proceeds of any insurance and any other legal rights.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 juil. 2014
    Livré le 03 juil. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine I Gp Limited as Security Agent
    Transactions
    • 03 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge on company assets
    Créé le 24 juil. 2008
    Livré le 12 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,638.38 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First floating charge all the undertaking and goodwill of the borrower and its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Security Centres (GB) Limited Executive Retirement Benefit Scheme
    Transactions
    • 12 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 01 sept. 2006
    Livré le 12 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Twenty five thousand pounds due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Air conditioning system.
    Personnes ayant droit
    • Security Centres E R B S
    Transactions
    • 12 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 13 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 janv. 1999
    Livré le 21 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and all security centres holdings (G.b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Single debenture
    Créé le 30 mars 1993
    Livré le 01 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0