SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED

SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02353406
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BEVERLEY JANE MARSH, VANTIS BUSINESS RECOVERY SERVICES
    VANTIS BUSINESS RECOVERY SERVICES
    104-106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SIMPSON INDUSTRIES LIMITED28 juin 199128 juin 1991
    MAXSYS LIMITED07 janv. 199107 janv. 1991
    DAYSHARP LIMITED28 févr. 198928 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 oct. 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juil. 2011

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    9 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2010

    5 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 28 avr. 2009

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 16 janv. 2009

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages287

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 mai 2009

    2 pages3.6

    Rapport du séquestre administratif

    27 pages3.10

    Déclaration des affaires en administration judiciaire suite au rapport aux créanciers

    5 pages3.3

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages405(1)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages395

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SIMPSON, John Michael
    57 Albert Road
    B63 4SW Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    57 Albert Road
    B63 4SW Halesowen
    West Midlands
    British69804950001
    SIMPSON, John Alfred
    Field Cottage Farm Uffmoor Lane
    Romsley
    B62 0NW Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    Field Cottage Farm Uffmoor Lane
    Romsley
    B62 0NW Halesowen
    West Midlands
    British13770250001
    CHAMPANERIA, Narendra Kumar
    12 Foxlands Drive
    B72 1YZ Sutton Coldfield
    Secrétaire
    12 Foxlands Drive
    B72 1YZ Sutton Coldfield
    British73506110002
    CLEMENT, Norman Howard
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    Secrétaire
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    British36402170001
    CLEMENT, Norman Howard
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    Administrateur
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    British36402170001
    EALES, Darryl Charles
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish2886080001
    EALES, Darryl
    6 Redwood Close
    Hollywood
    B47 5QD Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    6 Redwood Close
    Hollywood
    B47 5QD Birmingham
    West Midlands
    British33214220002

    SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 09 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    56/58 hainge road, tividale, warley, west midlands, sandwell t/no WM168255 and the plant, machinery and fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 09 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 oct. 2006
    Livré le 12 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    56/58 hainge road tividale warley west midlands t/nos WM168255 and WM1963. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 18 oct. 1996
    Livré le 26 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    56/58 hainge road tividale warley west midlands. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 avr. 1995
    Livré le 02 mai 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the north side of rocks lane barrow gurney woodspring avon t/no: av 213285. fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of novation
    Créé le 13 mai 1992
    Livré le 26 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargees on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Assets and undertakings of the company see form 395 ref M529C.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited
    • County Natwest Limited
    Transactions
    • 26 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 mars 1992
    Livré le 17 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transactions
    • 17 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 août 1991
    Livré le 15 août 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 2007Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 12 mai 2007Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
      • Numéro de dossier 1

    SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 août 1991Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    One Colmore Row
    B3 2DB Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    One Colmore Row
    B3 2DB Birmingham
    Ian Best
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    2
    DateType
    21 août 2012Dissolved on
    16 janv. 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan Mark Birch
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Beverley Jane Marsh
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Gerald Clifford Smith
    Frp Advisory Llp 104-106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    Frp Advisory Llp 104-106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0