DISTRICT ENERGY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDISTRICT ENERGY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02362017
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    • Production d'électricité (35110) / Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

    Où se situe DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor, Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED19 mars 199919 mars 1999
    BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED26 févr. 199926 févr. 1999
    NE GENERATION LIMITED16 févr. 199416 févr. 1994
    NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD.06 avr. 199006 avr. 1990
    SIGNKIT LIMITED16 mars 198916 mars 1989

    Quels sont les derniers comptes de DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Andrew Robert Koss en tant qu'administrateur le 03 août 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nauman Ahmad en tant que directeur le 03 août 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sam Kieron Wither en tant que directeur le 30 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul David Tomlinson en tant que directeur le 30 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England à 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA le 18 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Stephen Christopher Hands en tant que secrétaire le 01 avr. 2019

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA à Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS le 18 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Andrew Joseph Mountford en tant que secrétaire le 01 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    17 pagesAA

    Nomination de Mr Paul David Tomlinson en tant qu'administrateur le 12 févr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sriram Narayanan en tant que directeur le 12 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Peter Addis en tant que directeur le 31 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 023620170007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 023620170008 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Stephen Christopher Hands en tant qu'administrateur le 31 mai 2018

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANDS, Stephen Christopher
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Secrétaire
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    257684290001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish205116300001
    KOSS, Andrew Robert
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Administrateur
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    EnglandEnglish157160710002
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Secrétaire
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Secrétaire
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Secrétaire
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    GRANT, Paul Robert
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Secrétaire
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    170448160001
    LAWRIE, Karen Nicola
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    Secrétaire
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    British138732390001
    MELVILLE, John Rex
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    British12057640001
    MOUNTFORD, Andrew Joseph
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Secrétaire
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    244885560001
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    ADDIS, Jonathan Peter
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Administrateur
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    EnglandBritish260439420001
    AHMAD, Nauman
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Administrateur
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandPakistani246516040001
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Administrateur
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish50003350005
    BERESFORD, Nigel Stephen
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    Administrateur
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    United KingdomEnglish140458520001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BLISS, Simon Richard Weston
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    Administrateur
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    ScotlandBritish82638440001
    BROOKSHAW, Terry
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British78425070001
    CLEMENTS, Andrew Arthur
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    Administrateur
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    British52249820001
    COLEY, William Alfred
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British90266090006
    DOWN, Leonard Michael
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    Administrateur
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    British58057730001
    EMRICH, Timothy Wayne
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Administrateur
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    United KingdomAmerican159180900001
    HOLLINS, Peter Thomas
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Administrateur
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    British56803330002
    JEFFREY, Robin Campbell, Dr
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    Administrateur
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    British34426500002
    JOHNSON, Christopher Brian
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    Administrateur
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    United KingdomBritish46900180001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KUSTERER, Thomas Andreas
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    United KingdomGerman137548090001
    LANGLEY, Michael James
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    British70818670002
    LOUGH, Keith Geddes
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Administrateur
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    United KingdomBritish101630860001
    LOW, Michael Brian John
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British76638420001
    MACDONALD, Jean Elizabeth
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    ScotlandBritish4947170004
    MARSHALL, Richard Allan Jeffrey
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish151085170001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DISTRICT ENERGY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    06 avr. 2016
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement7385282
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DISTRICT ENERGY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 nov. 2015
    Livré le 20 nov. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 20 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 nov. 2015
    Livré le 19 nov. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (in Its Capacity as Security Trustee)
    Transactions
    • 19 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2014
    Livré le 20 août 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 20 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2014
    Livré le 20 août 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 20 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2005
    Livré le 17 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nuclear Generation Decommissioning Fund Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of amendment
    Créé le 28 nov. 2002
    Livré le 16 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 16 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 2002
    Livré le 09 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 09 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0