DISTRICT ENERGY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DISTRICT ENERGY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02362017 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DISTRICT ENERGY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court B91 2AA Solihull England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DISTRICT ENERGY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour DISTRICT ENERGY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Nomination de Mr Andrew Robert Koss en tant qu'administrateur le 03 août 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nauman Ahmad en tant que directeur le 03 août 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Sam Kieron Wither en tant que directeur le 30 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 pages | AD03 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 pages | AD02 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 17 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Paul David Tomlinson en tant que directeur le 30 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England à 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA le 18 avr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Mr Stephen Christopher Hands en tant que secrétaire le 01 avr. 2019 | 2 pages | AP03 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA à Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS le 18 avr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Joseph Mountford en tant que secrétaire le 01 avr. 2019 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 17 pages | AA | ||
Nomination de Mr Paul David Tomlinson en tant qu'administrateur le 12 févr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Sriram Narayanan en tant que directeur le 12 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Jonathan Peter Addis en tant que directeur le 31 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Satisfaction de la charge 023620170007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 023620170008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Stephen Christopher Hands en tant qu'administrateur le 31 mai 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de DISTRICT ENERGY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDS, Stephen Christopher | Secrétaire | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | 257684290001 | |||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Administrateur | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 205116300001 | |||||
| KOSS, Andrew Robert | Administrateur | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | England | English | 157160710002 | |||||
| ALLEN, Anthony | Secrétaire | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Secrétaire | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Secrétaire | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| GRANT, Paul Robert | Secrétaire | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | 170448160001 | |||||||
| LAWRIE, Karen Nicola | Secrétaire | Bishops Frome WR6 5AS Worcester Boscombe House Worcestershire | British | 138732390001 | ||||||
| MELVILLE, John Rex | Secrétaire | Haileywood 3 Birchen Lane RH16 1RY Haywards Heath West Sussex | British | 12057640001 | ||||||
| MOUNTFORD, Andrew Joseph | Secrétaire | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | 244885560001 | |||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Secrétaire | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Secrétaire | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| ADDIS, Jonathan Peter | Administrateur | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | England | British | 260439420001 | |||||
| AHMAD, Nauman | Administrateur | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | Pakistani | 246516040001 | |||||
| ALLEN, Anthony | Administrateur | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Administrateur | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | United Kingdom | British | 50003350005 | |||||
| BERESFORD, Nigel Stephen | Administrateur | c/o Edf Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 England | United Kingdom | English | 140458520001 | |||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Administrateur | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BLISS, Simon Richard Weston | Administrateur | Edgehill West Glen Road PA13 4PH Kilmalcolm | Scotland | British | 82638440001 | |||||
| BROOKSHAW, Terry | Administrateur | Saddlers Field Bowbridge Lane, Prestbury GL52 3BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 78425070001 | ||||||
| CLEMENTS, Andrew Arthur | Administrateur | 27 Grange Court Road Westbury On Trym BS9 4DR Bristol | British | 52249820001 | ||||||
| COLEY, William Alfred | Administrateur | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 90266090006 | ||||||
| DOWN, Leonard Michael | Administrateur | 6 King Malcolm Close EH10 7JB Edinburgh | British | 58057730001 | ||||||
| EMRICH, Timothy Wayne | Administrateur | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | United Kingdom | American | 159180900001 | |||||
| HOLLINS, Peter Thomas | Administrateur | 10d Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh | British | 56803330002 | ||||||
| JEFFREY, Robin Campbell, Dr | Administrateur | 71d Partickhill Road G11 5AD Glasgow | British | 34426500002 | ||||||
| JOHNSON, Christopher Brian | Administrateur | 31 Merevale Road GL2 0QX Gloucester | United Kingdom | British | 46900180001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Administrateur | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Administrateur | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KUSTERER, Thomas Andreas | Administrateur | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | German | 137548090001 | |||||
| LANGLEY, Michael James | Administrateur | 13 Nelson Street EH3 6LF Edinburgh Midlothian | British | 70818670002 | ||||||
| LOUGH, Keith Geddes | Administrateur | Lochside PA12 4JH Lochwinnoch Renfrewshire | United Kingdom | British | 101630860001 | |||||
| LOW, Michael Brian John | Administrateur | Grange House Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 76638420001 | ||||||
| MACDONALD, Jean Elizabeth | Administrateur | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | Scotland | British | 4947170004 | |||||
| MARSHALL, Richard Allan Jeffrey | Administrateur | c/o British Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | England | British | 151085170001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DISTRICT ENERGY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Power Reserve Ltd | 06 avr. 2016 | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
DISTRICT ENERGY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 16 nov. 2015 Livré le 20 nov. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 16 nov. 2015 Livré le 19 nov. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 13 août 2014 Livré le 20 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 13 août 2014 Livré le 20 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 janv. 2005 Livré le 17 janv. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of amendment | Créé le 28 nov. 2002 Livré le 16 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 sept. 2002 Livré le 09 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0