SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02367333 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED ?
| Adresse du siège social | 60 Fenchurch Street EC3M 4AD London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher David Pinney en tant qu'administrateur le 22 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Victor Muress en tant que directeur le 22 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 déc. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 01 nov. 2021
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019 | 1 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Raper en tant que directeur le 12 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 déc. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Sutton en tant que directeur le 07 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Raper en tant qu'administrateur le 07 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Corporation Service Company (Uk) Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Victor Muress en tant qu'administrateur le 20 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Edward Jenner en tant qu'administrateur le 20 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Domenick C. Di Cicco en tant que directeur le 19 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Meera Odedra en tant que directeur le 20 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNER, John Edward | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | Irish | 183383870001 | |||||||||
| PINNEY, Christopher David | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 158868090001 | |||||||||
| BRADFORD, Timothy | Secrétaire | 19 Meadowland Road Shotgate SS11 8XW Wickford Essex | British | 35465770001 | ||||||||||
| COUGHLAN, Edward | Secrétaire | Johore 25a London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | 70618120001 | ||||||||||
| DI CICCO, Domenick | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | 207651010001 | |||||||||||
| ONGLEY, David Anthony | Secrétaire | 52 The Ridgeway Southborough TN4 0DE Tunbridge Wells Kent | British | 30244060001 | ||||||||||
| TREDGOLD, Sharron | Secrétaire | C/O Cunningham Iap Limited International House 1 St Katharines Way E1W 1UU London International House Uk | 156942500001 | |||||||||||
| TUBB, Elizabeth Janet Mary | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | 164085800001 | |||||||||||
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED | Secrétaire | Bank Street Level 29 E14 5DS London 40 England |
| 216788570001 | ||||||||||
| BRADFORD, Natalie | Administrateur | 19 Meadowland Road Shotgate SS11 8XW Wickford Essex | British | 9130900001 | ||||||||||
| BRADFORD, Timothy | Administrateur | 19 Meadowland Road Shotgate SS11 8XW Wickford Essex | British | 35465770001 | ||||||||||
| BRUCE, David Julian | Administrateur | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | United Kingdom | British | 110877530002 | |||||||||
| DI CICCO, Domenick C. | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United States | American | 207059350001 | |||||||||
| GRANT, Alexander James | Administrateur | Slade The Heath Dedham CO7 6BU Colchester Essex | United Kingdom | British | 23211410001 | |||||||||
| HALL, David Edward | Administrateur | Tudor Cottage Mill End Green Great Easton CM6 2DW Dunmow Essex | United Kingdom | British | 210449830001 | |||||||||
| MURESS, Ian Victor | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United Kingdom | British | 107295730001 | |||||||||
| ODEDRA, Meera | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 207219690001 | |||||||||
| ONGLEY, David Anthony | Administrateur | 52 The Ridgeway Southborough TN4 0DE Tunbridge Wells Kent | British | 30244060001 | ||||||||||
| PANES, Christopher Michael | Administrateur | C/O Cunningham Iap Limited International House 1 St Katharines Way E1W 1UU London International House Uk | United Kingdom | British | 23211380010 | |||||||||
| RAPER, Stephen | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 259503170001 | |||||||||
| SUTTON, Jonathan Guy | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 215482550001 | |||||||||
| TRAVIS, Rupert James Leigh | Administrateur | C/O Cunningham Iap Limited International House 1 St Katharines Way E1W 1UU London International House Uk | England | British | 45832710001 | |||||||||
| TREDGOLD, Sharron Lynn | Administrateur | C/O Cunningham Iap Limited International House 1 St Katharines Way E1W 1UU London International House Uk | United Kingdom | British | 71466570003 | |||||||||
| TUBB, Elizabeth Janet Mary | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United Kingdom | British | 162278590001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SEDGWICK DEBT RECOVERY & INVESTIGATION LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgwick Risk Services Limited | 06 avr. 2016 | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0