INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED

INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02368803
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MILLENELM LIMITED06 avr. 198906 avr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 nov. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 pagesAD04

    Cessation de la nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2017

    2 pagesAP04

    Nomination de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited en tant qu'administrateur le 31 mai 2017

    2 pagesAP02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    8 pagesAA

    Nomination de Tarek Sayed en tant qu'administrateur le 05 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Mullock en tant que directeur le 05 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mai 2016

    État du capital au 26 mai 2016

    • Capital: GBP 92
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2015

    État du capital au 29 juil. 2015

    • Capital: GBP 92
    SH01

    Nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant qu'administrateur le 30 mars 2015

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Kerry Phillip en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Richard Mullock en tant qu'administrateur le 30 mars 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Nomination de Kerry Phillip en tant qu'administrateur le 01 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2303594
    232519770001
    MAY, Andrew George Fraser
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish134139330002
    SAYED, Tarek
    Cypress Court
    GU25 4TB Virginia Water
    1
    England
    England
    Administrateur
    Cypress Court
    GU25 4TB Virginia Water
    1
    England
    England
    United KingdomBritish215751210001
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2303594
    232519770001
    CHALFIN, Lynda Cheryl
    Offchurch House
    Offchurch
    CV33 9AW Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    Offchurch House
    Offchurch
    CV33 9AW Leamington Spa
    Warwickshire
    British104262970001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secrétaire
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secrétaire
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152558740001
    RAYNER, Timothy Michael
    42 Gravel Lane
    SK9 6LQ Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    42 Gravel Lane
    SK9 6LQ Wilmslow
    Cheshire
    British51794370001
    UU SECRETARIAT LIMITED
    Dawson House
    Great Sankey
    WA5 3LW Cheshire
    Secrétaire
    Dawson House
    Great Sankey
    WA5 3LW Cheshire
    94063410002
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Administrateur
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    BARBER, Simon John
    1 Tern Drive
    Poynton
    SK12 1HR Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    1 Tern Drive
    Poynton
    SK12 1HR Stockport
    Cheshire
    British113410690001
    BULLOCK, Andrew Robert
    33 The Green
    Evenley
    NN13 5SH Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    33 The Green
    Evenley
    NN13 5SH Brackley
    Northamptonshire
    British70768340001
    CHALFIN, John Andrew
    Offchurch House
    Offchurch
    CV33 9AW Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Offchurch House
    Offchurch
    CV33 9AW Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish23866910001
    CHALFIN, Lynda Cheryl
    Offchurch House
    Offchurch
    CV33 9AW Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Offchurch House
    Offchurch
    CV33 9AW Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish104262970001
    CRAWFORD, David William
    Paices Hill
    RG7 4PG Aldermaston
    Barn End House
    Berkshire
    Administrateur
    Paices Hill
    RG7 4PG Aldermaston
    Barn End House
    Berkshire
    EnglandBritish315434370001
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    DEERING, Jeremy Robert John
    58 Elm Grove
    Didsbury
    M20 6PN Manchester
    Administrateur
    58 Elm Grove
    Didsbury
    M20 6PN Manchester
    British56662820003
    GREAVES, Paul John
    Todmorden Edge South Parkin Lane
    OL14 7JF Todmorden
    Lancashire
    Administrateur
    Todmorden Edge South Parkin Lane
    OL14 7JF Todmorden
    Lancashire
    United KingdomBritish57239400001
    GREAVES, Paul John
    Todmorden Edge South Parkin Lane
    OL14 7JF Todmorden
    Lancashire
    Administrateur
    Todmorden Edge South Parkin Lane
    OL14 7JF Todmorden
    Lancashire
    United KingdomBritish57239400001
    LAWTON, Paul Stephen
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Cheshire
    Drakelow House
    Administrateur
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Cheshire
    Drakelow House
    United KingdomBritish262931860001
    LOGAN, Hugh
    7 Tresham Drive
    Grappenhall
    WA4 3DU Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    7 Tresham Drive
    Grappenhall
    WA4 3DU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish119332280001
    MAGUIRE, John Noel
    Silver Birch
    Sandy Lane, Ivy Hatch
    TN15 0PB Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Silver Birch
    Sandy Lane, Ivy Hatch
    TN15 0PB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish169410600001
    MALE, Philip Stewart
    Royal Drive
    Friern Barnet
    N11 3FL London
    39 Princess Park Manor
    Administrateur
    Royal Drive
    Friern Barnet
    N11 3FL London
    39 Princess Park Manor
    United KingdomBritish112888290003
    MULLOCK, Richard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish193570430001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    WILSON, Geoffrey Paul
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish55805310001
    WOOLHOUSE, John Anthony
    30 Cherrybank Road
    S8 8RA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    30 Cherrybank Road
    S8 8RA Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish2885600001
    YOUNG, Gavin Macarthur
    11 Lyme Grove
    WA14 2AD Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    11 Lyme Grove
    WA14 2AD Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish19594590001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4171876
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 août 1999
    Livré le 12 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 1990
    Livré le 17 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 nov. 1989
    Livré le 29 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0