DCS AUTOMOTIVE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DCS AUTOMOTIVE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02377414 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DCS AUTOMOTIVE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1200 Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DCS AUTOMOTIVE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour DCS AUTOMOTIVE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 09 janv. 2012
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 4 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 5 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 16 déc. 2011
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 11 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Terry Wallace Jones en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Carlan Cooper en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Norman Tommy Barras en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Theron Brockman en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Dan Steven Agan en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Maxey Nalley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Moss en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 11 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 12 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DCS AUTOMOTIVE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSS, Michael Craig | Secrétaire | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | American | 121496770001 | ||||||
| AGAN, Dan Steven | Administrateur | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 United Kingdom | United States | American | 84053880001 | |||||
| BARRAS, Norman Tommy | Administrateur | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 United Kingdom | United States | American | 84053860001 | |||||
| BROCKMAN, Robert Theron | Administrateur | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 United Kingdom | United States | American | 158497330001 | |||||
| BURNETT, Robert David | Administrateur | Post Oak Run 77355 Magnolia 28122 Texas Usa | United States | American | 121495910001 | |||||
| COOPER, Carlan Max | Administrateur | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 United Kingdom | Usa | United States | 136536270001 | |||||
| JONES, Terry Wallace | Administrateur | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 United Kingdom | United States | American | 84053830001 | |||||
| NALLEY, Robert Maxey | Administrateur | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 United Kingdom | United States | American | 84053700001 | |||||
| BATE, Nicholas John | Secrétaire | St James Court 107 Wilderspool Causeway WA4 6PS Warrington Cheshire | British | 10672220001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Secrétaire | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Secrétaire | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Stephen | Secrétaire | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | British | 89866330001 | ||||||
| ROGERS, Wendy Fiona | Secrétaire | Fulbrook House 14 West End HP22 5TT Weston Turville Buckinghamshire | British | 72773920003 | ||||||
| SMITH, David Anthony | Secrétaire | 15 Waveney Drive WA14 4UQ Altrincham Cheshire | British | 17924810001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Administrateur | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| BROWN, Michael Stewart | Administrateur | Flat 6 Derwent Park House New Road DE22 1DR Derby | British | 86327240001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Stephen | Administrateur | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | United Kingdom | British | 89866330001 | |||||
| EMBLEY, Paul | Administrateur | 23 Roosevelt Avenue SG17 5UR Shefford Bedfordshire | British | 66065980001 | ||||||
| FLEGG, Ronald Edwin | Administrateur | 14 Worthington Close Henbury SK11 9NS Macclesfield Cheshire | British | 10672250001 | ||||||
| FORSYTH, Andrew James | Administrateur | Well House Farm Pateley Bridge HG3 5NG Harrogate North Yorkshire | England | British | 64591610001 | |||||
| GESWEIN, Gregory Thomas | Administrateur | 3625 Wood Hollow Dayton Ohio 45429 Usa | American | 114993100001 | ||||||
| GUJRAL, Ben | Administrateur | Churchfield Lodge Churchfield Path EN8 9EG Cheshunt Hertfordshire | British | 94654870001 | ||||||
| HARRISON, Jeffrey Malcolm | Administrateur | 54 Stratford Road B60 1AU Bromsgrove Worcestershire | British | 16150470002 | ||||||
| LAWSON, Nicholas St John | Administrateur | Ashton Hillbrow Road KT10 9UD Esher Surrey | England | British | 43842220001 | |||||
| MACKENZIE, Iain Robertson | Administrateur | Corbett House 15 Corbett Avenue WR9 7BE Droitwich Worcestershire | British | 35613150001 | ||||||
| MARTIN, Robert Edward | Administrateur | 25 Syddal Road Bramhall SK7 1AB Stockport Cheshire | England | British | 24767980001 | |||||
| MERRIMAN, Christopher Peter | Administrateur | 1 Oakdene Drive Barnt Green B45 8LQ Birmingham West Midlands | British | 63578740002 | ||||||
| MOSS, Michael Craig | Administrateur | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | United States | American | 121496770001 | |||||
| SMITH, David Anthony | Administrateur | 15 Waveney Drive WA14 4UQ Altrincham Cheshire | British | 17924810001 | ||||||
| SOANES, David | Administrateur | Fencewood House Slanting Hill RG18 9QQ Cold Ash Berkshire | British | 80021380001 | ||||||
| SPENCE, Raymond Leslie | Administrateur | 1 Mill Lane WS14 0DP Lichfield Staffordshire | British | 46677090001 | ||||||
| VENTURA, Douglas Michael | Administrateur | 3840 Winning Stakes Way Mason Ohio 45040 Usa | American | 111985510001 | ||||||
| WOODALL, Frederick Peter | Administrateur | The Ridge Pine Walks Prenton CH42 8NF Wirral Merseyside | British | 74795530001 | ||||||
| YAPP, Stephen | Administrateur | 4 The Tovells Off School Lane Ufford IP13 6HF Woodbridge Suffolk | England | British | 42686850001 |
DCS AUTOMOTIVE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 11 oct. 2005 Livré le 21 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 31 mars 2004 Livré le 01 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 05 juin 2000 Livré le 13 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 janv. 1995 Livré le 27 janv. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0