EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED

EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02377630
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Grosvenor Street
    London
    W1K 4BJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EDGE PROPERTIES PLC05 déc. 198905 déc. 1989
    EDGE DEVELOPMENTS LIMITED01 juin 198901 juin 1989
    RAPID 8193 LIMITED28 avr. 198928 avr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    ASAHVOAM

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Co to be struck off 11/10/2010
    RES13

    Cessation de la nomination de Martin Jespon en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XLT4HO5P

    Cessation de la nomination de Andrew Thomson en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XLT4IO5Q

    Cessation de la nomination de Lawrence Hutchings en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XLT4GO5O

    Cessation de la nomination de Peter Cole en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XLT4FO5N

    Cessation de la nomination de Andrew Berger-North en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XLT4EO5M

    legacy

    1 pagesSH20
    AKCLAMQD

    État du capital au 24 août 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19
    AKCLBMQE

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    AKCKCMQE

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de diminution du capital social autorisé

    RES05
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    XBR3DK32

    Cessation de la nomination de David Atkins en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XLAYME2S

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA
    AGNPOC8A

    legacy

    5 pages363a
    XH5DNA92

    legacy

    9 pages288a
    A5MT45EH

    legacy

    1 pages288b
    A5CT45E7

    legacy

    9 pages288a
    A5MZB5EU

    legacy

    9 pages288a
    A5D0F5EQ

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA
    LHHOG3G6

    legacy

    4 pages363a
    X47CK059

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAYDON, Stuart John
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Secrétaire
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British3175210001
    HARDIE, Nicholas Alan Scott
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    Administrateur
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    EnglandBritishFinancial Controller56627250001
    BURKS, Philip Adrian
    Marchmont Road
    TW10 6HQ Richmond
    27
    Surrey
    Secrétaire
    Marchmont Road
    TW10 6HQ Richmond
    27
    Surrey
    British81632970001
    GIBSON, James Ernest
    84 Mallinson Road
    SW11 1BN London
    Secrétaire
    84 Mallinson Road
    SW11 1BN London
    British81633220001
    HOLLOCKS, Ian Michael
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    Secrétaire
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    BritishCompany Secretary61055270001
    JUKES, Anthony James
    4 Dale Gardens
    Woodford Wells
    IG8 0PB Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    4 Dale Gardens
    Woodford Wells
    IG8 0PB Woodford Green
    Essex
    British9712820001
    ALFORD, Nicholas Brian Treseder
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Great BritainBritishChartered Surveyor126970360001
    ATKINS, David John
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    Administrateur
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSurveyor144036070001
    BAKER, Michael John
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    Administrateur
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    BritishSurveyor77729120001
    BERGER-NORTH, Andrew John
    Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    1
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor134630050001
    BURKS, Philip Adrian
    Marchmont Road
    TW10 6HQ Richmond
    27
    Surrey
    Administrateur
    Marchmont Road
    TW10 6HQ Richmond
    27
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Developer81632970001
    BYWATER, John Andrew
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor71820020003
    COLE, Peter William Beaumont
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor51145990001
    EMERY, Jonathan Michael
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    Administrateur
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    BritishDevelopment Manager78621400001
    EVANS, Christopher Mark Stephen
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    Administrateur
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    EnglandBritishChartered Surveyor71333340001
    GIBSON, James Ernest
    84 Mallinson Road
    SW11 1BN London
    Administrateur
    84 Mallinson Road
    SW11 1BN London
    EnglandBritishFinance Director81633220001
    HARRIS, Iain Farlane Sim
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant56363000001
    HEWSON, Andrew Nicholas
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    BritishDirector8607090005
    HUBERMAN, Paul Laurence
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    Administrateur
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    EnglandBritishDirector3470530003
    HUTCHINGS, Lawrence Francis
    Brody House
    Strype Street
    E1 7LQ London
    Flat 503
    United Kingdom
    Administrateur
    Brody House
    Strype Street
    E1 7LQ London
    Flat 503
    United Kingdom
    EnglandBritishAsset Manager134630060001
    JESPON, Martin Clive
    Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    5
    Surrey
    Administrateur
    Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    5
    Surrey
    BritishChartered Surveyor135066940001
    LEWIS PRATT, Andrew
    34 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    Administrateur
    34 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    BritishProperty Developer60050050002
    MUSSON, Geoffrey Charles
    Orchard Grove Bolter End Common
    Lane End
    HP14 3LU High Wycombe
    Bucks
    Administrateur
    Orchard Grove Bolter End Common
    Lane End
    HP14 3LU High Wycombe
    Bucks
    BritishCompany Director2087340001
    ROBINSON, Stephen David
    1 Leycroft Way
    AL5 1JW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Leycroft Way
    AL5 1JW Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor41829050001
    THOMSON, Andrew James Gray
    Niton Street
    SW6 6NJ London
    10
    Administrateur
    Niton Street
    SW6 6NJ London
    10
    EnglandBritishIt Director97267360001
    VETCH, Nicholas John
    Byways
    Steep
    GU32 1AD Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Byways
    Steep
    GU32 1AD Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritishProperty Developer6270470003
    WALTON, Timothy Paul
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector59971310002
    WEISS, Edward Louis Samuel
    Beeches 17 Stratton Road
    HP9 1HR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Beeches 17 Stratton Road
    HP9 1HR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChairman10961490001
    WHIGHT, Paul James
    24d Thameside
    RG9 2LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    24d Thameside
    RG9 2LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    BritishCompany Director110745030002
    WRIGHT, Geoffrey Harcroft
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    BritishBuilding Surveyor8585700001

    EDGE PROPERTIES HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 16 juin 1995
    Livré le 05 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined in tha facility agreement) to the chargee under the terms of or pursuant to the credit facility agreement dated 16 june 1995
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to two ordinary shares of £1 each in the capital of edge developments (croydon no. 2) limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken- Und Wechsel - Bank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 05 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of shares
    Créé le 12 avr. 1995
    Livré le 20 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due from edge property investment company limited or the company to the chargee as agent for the finance parties under the terms of each finance document
    Brèves mentions
    All dividends paid or payable after 12 april 1995 on all or any of the shares (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 20 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over sterling deposit account
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 08 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee
    Brèves mentions
    The sterling deposit account no: 12067237 opened by the company in the books of the bank and all monies which may from time to time constitute the balance standing to the credit of the account and alll right title and interest therein.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 08 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 28 juin 1991
    Livré le 12 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 26/3/91 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 28/3/9U
    Brèves mentions
    The benefits dividends arising in respect of 35, 178 issued £1 preferred ordinary shares in the receipt of edge retal investment company limited.
    Personnes ayant droit
    • Trust Union Finance Limited
    Transactions
    • 12 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 1991
    Livré le 10 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 26.3.91 and under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Benefits & advantages whatsoever at any time, accruing offered or arising (including without limitation any dividends or other distributions declared) in respect of or incl incidental to the shares referred to on the 395 (see form 395 & cont- sheet for full details).
    Personnes ayant droit
    • Trust Union Finance Limited
    Transactions
    • 10 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 nov. 1990
    Livré le 06 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the development facility agreement or under any other agreement made pursuant to the master facility agreement dated 2ND october 1989.
    Brèves mentions
    Flaoting charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Trust Union Finance Limited
    Transactions
    • 06 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 07 juil. 1989
    Livré le 20 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • T R Property Investment Trust PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 07 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 juil. 1989
    Livré le 21 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0