COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED

COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02379221
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED ?

    • Transport fluvial de voyageurs (50300) / Transports et stockage

    Où se situe COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Maritime Centre
    Port Of Liverpool
    L21 1LA
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 13 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancel; share prem a/c 29/03/2016
    RES13

    Cessation de la nomination de John Whittaker en tant que directeur le 29 mars 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas Eardley Allison en tant que directeur le 29 mars 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2016

    État du capital au 08 janv. 2016

    • Capital: GBP 128,600
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    13 pagesAA

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Résolutions

    Resolutions
    19 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Whittaker le 07 avr. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 nov. 2014

    État du capital au 27 nov. 2014

    • Capital: GBP 128,600
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2014

    État du capital au 14 janv. 2014

    • Capital: GBP 128,600
    SH01

    Comptes établis au 31 mars 2013

    13 pagesAA

    legacy

    4 pagesMG02

    Comptes établis au 31 mars 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Ian Graeme Lloyd Charnock en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 mars 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Secrétaire
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Other140064590001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165341530001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Administrateur
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    ScotlandBritish1037730004
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Administrateur
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    Administrateur
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    ScotlandBritish86622660005
    CARTER, William
    7 Brows Lane
    L37 3HY Formby
    Administrateur
    7 Brows Lane
    L37 3HY Formby
    EnglandBritish50474650001
    CLIFF, Bernard
    7 Monks Way
    West Kirby
    L48 7ER Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    7 Monks Way
    West Kirby
    L48 7ER Wirral
    Merseyside
    British2637520001
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish30045540003
    FURLONG, Percival Trevor
    215 Queens Drive
    Wavertree
    L15 6YE Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    215 Queens Drive
    Wavertree
    L15 6YE Liverpool
    Merseyside
    British9867770001
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Administrateur
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    HILL, Michael Gerard
    6 Larkhill Lane
    Freshfield
    L37 1LX Formby
    Merseyside
    Administrateur
    6 Larkhill Lane
    Freshfield
    L37 1LX Formby
    Merseyside
    EnglandBritish52180800001
    JONES, Peter Anthony
    22a Victoria Road
    West Kirby
    CH48 3HL Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    22a Victoria Road
    West Kirby
    CH48 3HL Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish104612790001
    MASON, Geoffrey
    15 Ranelagh Drive North
    L19 9DS Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    15 Ranelagh Drive North
    L19 9DS Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish4171260001
    MURRAY, Leslie Porter
    36 Ballymorran Road
    Killinchy
    BT23 6UE Newtownards
    County Down
    Administrateur
    36 Ballymorran Road
    Killinchy
    BT23 6UE Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritish144389520001
    PORT, David Charles
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish58053990001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    WHITTAKER, John
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Administrateur
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Isle Of ManBritish1614010001

    COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed of accession
    Créé le 28 févr. 2007
    Livré le 13 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Secured Creditors
    Transactions
    • 13 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 06 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as security trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 06 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0