LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED

LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02381545
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED ?

    • Autres activités des agences de placement (78109) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LINK PROJECT SERVICES LIMITED12 janv. 199612 janv. 1996
    HUNTERS HILL CONSULTANTS LIMITED09 mai 198909 mai 1989

    Quels sont les derniers comptes de LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 janv. 2021

    20 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 janv. 2020

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 janv. 2019

    17 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    11 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesAM22

    Changement d'adresse du siège social de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL à Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU le 19 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 10 janv. 2017

    17 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian David Moreton le 24 nov. 2016

    3 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Resolve Partners Limited One America Square Crosswall London EC3N 2LB à Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL le 09 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 juil. 2016

    16 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    7 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de 2 Smithy Court Pemberton Business Park Wigan Lancashire WN3 6PS à C/O Resolve Partners Limited One America Square Crosswall London EC3N 2LB le 12 févr. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    48 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Carol Evelyn Moreton en tant que directeur le 06 mai 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew John Lyons en tant qu'administrateur le 06 mai 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLOOMFIELD, Ian Andrew
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    194339490001
    LYONS, Andrew John
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Administrateur
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    EnglandBritishCeo60705750001
    MORETON, Brian David
    Glenridding
    CA11 0NQ Penrith
    Mossdale
    England
    Administrateur
    Glenridding
    CA11 0NQ Penrith
    Mossdale
    England
    EnglandBritishCompany Director45819640003
    MORETON, Carol Evelyn
    Yew Tree Cottage
    Smithy Lane, Mawdesley
    L40 2QG Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage
    Smithy Lane, Mawdesley
    L40 2QG Ormskirk
    Lancashire
    British45819710001
    BRAND, Harold Mark
    Ryans Run Court
    TX 77478 Sugar Land
    2002
    Texas
    United States Of America
    Administrateur
    Ryans Run Court
    TX 77478 Sugar Land
    2002
    Texas
    United States Of America
    UsaUnited StatesManager139750880001
    CAVE, John Leslie
    Manor House
    Whittington
    LA6 2NU Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    Manor House
    Whittington
    LA6 2NU Carnforth
    Lancashire
    BritishProject Management Consultant20106670002
    MARSH, Stephen William
    Daneway Beaulieu Road
    Dibden Purlieu
    SO45 4JE Southampton
    Administrateur
    Daneway Beaulieu Road
    Dibden Purlieu
    SO45 4JE Southampton
    United KingdomBritishOperations Director63385140001
    MEENAN, Campbell Mckinven
    511 Sancroft
    Katy Houstow
    Texas
    77450
    Usa
    Administrateur
    511 Sancroft
    Katy Houstow
    Texas
    77450
    Usa
    BritishConsultant37731340003
    MOORE, David George Newton
    48 Marlborough Close
    BL0 9YU Ramsbottom
    Lancashire
    Administrateur
    48 Marlborough Close
    BL0 9YU Ramsbottom
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant74720760001
    MORETON, Carol Evelyn
    Yew Tree Cottage
    Smithy Lane, Mawdesley
    L40 2QG Ormskirk
    Lancashire
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Smithy Lane, Mawdesley
    L40 2QG Ormskirk
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director45819710001
    PALMER, Christopher James
    74 Springfield Crescent
    Kibworth Beauchamp
    LE8 0LH Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    74 Springfield Crescent
    Kibworth Beauchamp
    LE8 0LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishFinance Director5948590002

    LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 déc. 2014
    Livré le 22 déc. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 déc. 2013
    Livré le 24 déc. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 24 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 15 nov. 2012
    Livré le 28 nov. 2012
    En cours
    Montant garanti
    £1,200,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rc Dando LLP
    Transactions
    • 28 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 26 juil. 2012
    Livré le 28 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 mai 2012
    Livré le 02 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    2 smithy court, pemberton business park, wigan, lancashire, t/no: MAN89815. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Faunus Group International, Inc.
    Transactions
    • 02 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 02 févr. 2011
    Livré le 04 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 10 déc. 2010
    Livré le 14 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 14 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 10 déc. 2010
    Livré le 14 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 14 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchsed debts which fail to vest
    Créé le 13 juil. 2007
    Livré le 17 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (the Security Holder)
    Transactions
    • 17 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 01 déc. 2005
    Livré le 02 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 02 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 08 déc. 2004
    Livré le 09 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 09 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on debts and related rights
    Créé le 19 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All debts pursuant to a factoring agreement and all rights under the supply contract; all indemnities,guarantees,insurances and securities........ See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating chrge
    Créé le 02 mars 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    LINK OIL & GAS PROFESSIONALS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 janv. 2016Administration started
    30 janv. 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    practitioner
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    practitioner
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    2
    DateType
    30 janv. 2018Commencement of winding up
    02 juil. 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Harris
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    practitioner
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Mark Supperstone
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0