EX HAMPS DEAC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEX HAMPS DEAC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02396152
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Portland
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DEACON INSURANCE SERVICES LIMITED16 juin 198916 juin 1989

    Quels sont les derniers comptes de EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    17 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 nov. 2014

    12 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Ian Sutherland en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Third Floor Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP* le 14 nov. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination de Ian Ronald Sutherland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Sutherland en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 déc. 2012

    2 pagesAA01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2013 au 30 déc. 2013

    3 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Michael Ramsey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name03 juin 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Kevin Michael Withington en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mai 2013

    État du capital au 31 mai 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Oliver en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Francis Ramsey en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Ronald Sutherland le 21 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Ian Ronald Sutherland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de EX HAMPS DEAC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    YE, Christina Hong
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    British133681410001
    WITHINGTON, Kevin Michael
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    Administrateur
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    EnglandEnglish178721390001
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Secrétaire
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    British148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Secrétaire
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    British57752860001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Secrétaire
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DUCKER, Elaine
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    British12261980001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secrétaire
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Secrétaire
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    British82018950001
    ZEALE, Nadine Catherine
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    Secrétaire
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    British58435360001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    Secrétaire
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    British22396670002
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish57752860001
    BOYD, Iain Grant
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    British51260620002
    CRAN, John Andrew George
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish61456650002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30526830004
    DUCKER, David George Bartholomew
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    Administrateur
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    British45548190004
    DUCKER, David George Bartholomew
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    Administrateur
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    British45548190002
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Administrateur
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritish16684130002
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74069620002
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    Administrateur
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritish62622410007
    OLIVER, David Martin
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish115764650001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Administrateur
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish82018950001
    PEJNOVIC, Tomislav
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritish204966490001
    PLUMB, Robert Henry Charles
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    Administrateur
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    EnglandBritish20686100001
    PURKISS, Julie
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    Administrateur
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    British99182850001
    RAMSEY, Michael Francis
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    Administrateur
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United KingdomBritish80310620002
    SMITH, James Robert Drummond
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    Administrateur
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    SpainBritish130443150001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish163582690001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189660790001
    WILLIAMS, Neil Vaughan
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish71561050001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    Administrateur
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    British22396670003

    EX HAMPS DEAC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental charge
    Créé le 02 janv. 2008
    Livré le 08 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (Formerly Known as the Governor and Company of the Bank of Scotland)(the Security Trustee)
    Transactions
    • 08 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Group debenture
    Créé le 26 juil. 2006
    Livré le 03 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transactions
    • 03 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 mars 2002
    Livré le 14 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company
    Créé le 08 déc. 1999
    Livré le 18 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 déc. 1998
    Livré le 05 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 05 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 sept. 1994
    Livré le 20 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,
    Transactions
    • 20 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EX HAMPS DEAC LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    04 févr. 2016Dissolved on
    06 nov. 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    practitioner
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Matthew Richard Meadley Wild
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    practitioner
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0