EX HAMPS DEAC LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EX HAMPS DEAC LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02396152 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EX HAMPS DEAC LIMITED ?
| Adresse du siège social | Portland 25 High Street RH10 1BG Crawley West Sussex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EX HAMPS DEAC LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EX HAMPS DEAC LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour EX HAMPS DEAC LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 17 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 nov. 2014 | 12 pages | 4.68 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Sutherland en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Third Floor Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP* le 14 nov. 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Ian Ronald Sutherland en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Sutherland en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 déc. 2012 | 2 pages | AA01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2013 au 30 déc. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Ramsey en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Nomination de Kevin Michael Withington en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Oliver en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Francis Ramsey en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Ronald Sutherland le 21 nov. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Ian Ronald Sutherland en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EX HAMPS DEAC LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE, Christina Hong | Secrétaire | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | British | 133681410001 | ||||||
| WITHINGTON, Kevin Michael | Administrateur | 25 High Street RH10 1BG Crawley Portland West Sussex | England | English | 178721390001 | |||||
| ATHERTON, Andrew James | Secrétaire | Beauchamp Westover Road Milford On Sea SO41 0PW Lymington Hampshire | British | 148270340001 | ||||||
| BALDWIN, Nicholas Charles | Secrétaire | 80 Pilford Heath Road BH21 2ND Wimborne Dorset | British | 57752860001 | ||||||
| BELLIS, Juliet Mary Susan | Secrétaire | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 69991160002 | ||||||
| DAVIS, Nigel Peter | Secrétaire | 66 Redway Drive TW2 7NW Twickenham Middlesex | British | 93673010001 | ||||||
| DUCKER, Elaine | Secrétaire | 9 Whincroft Drive Ferndown BH22 9LH Bournemouth Dorset | British | 12261980001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secrétaire | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| PALMER, Jeffrey Edward | Secrétaire | 22 Catalina Close BH23 4JG Christchurch Dorset | British | 82018950001 | ||||||
| ZEALE, Nadine Catherine | Secrétaire | 12 The Brewery The Maltings Church Street TW18 4XH Staines Middlesex | British | 58435360001 | ||||||
| ZEALE, Richard John Alexander | Secrétaire | The Clive Croft Road,Neacroft BH23 8JS Christchurch Dorset | British | 22396670002 | ||||||
| ATHERTON, Andrew James | Administrateur | Beauchamp Westover Road Milford On Sea SO41 0PW Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 148270340001 | |||||
| BALDWIN, Nicholas Charles | Administrateur | 80 Pilford Heath Road BH21 2ND Wimborne Dorset | England | British | 57752860001 | |||||
| BOYD, Iain Grant | Administrateur | 1 Highland View Close BH21 2QX Wimborne Dorset | British | 51260620002 | ||||||
| CRAN, John Andrew George | Administrateur | 19 Countess Gardens BH7 7RR Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 61456650002 | |||||
| DAVIS, Nigel Peter | Administrateur | 6 Boundary Park KT13 9RR Weybridge Surrey | England | British | 93673010002 | |||||
| DAVIS, Paul Malcolm | Administrateur | 3 Church Close WD7 8BJ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 30526830004 | |||||
| DUCKER, David George Bartholomew | Administrateur | 43 Groenhof Wezembeek Oppen FOREIGN 1970 Brussels Belgium | British | 45548190004 | ||||||
| DUCKER, David George Bartholomew | Administrateur | 9 Whincroft Drive BH22 9LH Ferndon Bournemouth | British | 45548190002 | ||||||
| GOODING, Jonathan Michael | Administrateur | 13 Albany Street NW1 4DX London | United Kingdom | British | 16684130002 | |||||
| JENKINSON, Andrew Timothy | Administrateur | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 74069620002 | |||||
| LIPMAN, Larry Glenn | Administrateur | 12 Park St James Prince Albert Road NW8 7LE St Johns Wood | England | British | 62622410007 | |||||
| OLIVER, David Martin | Administrateur | 13 Kirklee Circus G12 0TW Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 115764650001 | |||||
| PALMER, Jeffrey Edward | Administrateur | 22 Catalina Close BH23 4JG Christchurch Dorset | England | British | 82018950001 | |||||
| PEJNOVIC, Tomislav | Administrateur | 18 B Winchester Road GU32 3BL Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 204966490001 | |||||
| PLUMB, Robert Henry Charles | Administrateur | Uplands Cottage Whitchurch On Thames RG8 7HH Reading | England | British | 20686100001 | |||||
| PURKISS, Julie | Administrateur | 1 Headinglea 5 The Avenue BH13 6AA Poole Dorset | British | 99182850001 | ||||||
| RAMSEY, Michael Francis | Administrateur | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House | United Kingdom | British | 80310620002 | |||||
| SMITH, James Robert Drummond | Administrateur | 11 Wellesley Road CR0 2NW Croydon Caley Limited Phoenix House Surrey | Spain | British | 130443150001 | |||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Administrateur | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 163582690001 | |||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Administrateur | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 189660790001 | |||||
| WILLIAMS, Neil Vaughan | Administrateur | 1 Richmond Place TN2 5JZ Tunbridge Wells Kent | England | British | 71561050001 | |||||
| ZEALE, Richard John Alexander | Administrateur | The Whittle 24 Chewton Farm Road BH23 5QN Highcliffe Dorset | British | 22396670003 |
EX HAMPS DEAC LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental charge | Créé le 02 janv. 2008 Livré le 08 janv. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Group debenture | Créé le 26 juil. 2006 Livré le 03 août 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 mars 2002 Livré le 14 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company | Créé le 08 déc. 1999 Livré le 18 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 22 déc. 1998 Livré le 05 janv. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 12 sept. 1994 Livré le 20 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
EX HAMPS DEAC LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0