CSB HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CSB HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02397837 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CSB HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | 79 Caroline Street B3 1UP Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CSB HOLDINGS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2022 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2023 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2021 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CSB HOLDINGS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 juin 2023 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 06 juil. 2023 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 juin 2022 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour CSB HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 nov. 2024 | 16 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 nov. 2023 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Coins Building 11 st Laurence Way Slough Berkshire SL1 2EA à 79 Caroline Street Birmingham B3 1UP le 13 déc. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Louis Werner en tant que directeur le 29 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Timothy James en tant que directeur le 29 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Adrian Halls en tant qu'administrateur le 25 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2022 avec mises à jour | 8 pages | CS01 | ||||||||||||||
Statuts | 31 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 09 mars 2022
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Derek Leaver en tant que directeur le 25 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Leslie Cope en tant que directeur le 25 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2021 | 53 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2021 avec mises à jour | 9 pages | CS01 | ||||||||||||||
Rachat d'actions propres. | 3 pages | SH03 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 02 mars 2021
| 4 pages | SH06 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2020 | 50 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2020 avec mises à jour | 8 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2019 | 54 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2019 avec mises à jour | 9 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 47 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de CSB HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLS, Adrian | Secrétaire | Caroline Street B3 1UP Birmingham 79 | 193455080001 | |||||||
ARMITAGE, Timothy Peter | Administrateur | Caroline Street B3 1UP Birmingham 79 | United Kingdom | British | Company Director | 49179200001 | ||||
HALLS, Adrian | Administrateur | Caroline Street B3 1UP Birmingham 79 | England | British | Certified Accountant | 302647360001 | ||||
SULLIVAN, Lawrence John | Administrateur | Caroline Street B3 1UP Birmingham 79 | United Kingdom | British | Company Director | 2247440002 | ||||
BAKER, Philip | Secrétaire | 11 St Laurence Way SL1 2EA Slough The Coins Building Berkshire England | British | Chief Financial Officer | 119678640001 | |||||
CHAPMAN, Stuart Victor | Secrétaire | Arbrook 44 St. Mary`S Road KT22 8EY Leatherhead Surrey | British | 11854090001 | ||||||
CLAIR, Peter | Secrétaire | 11 Ackmar Road Parsons Green SW6 4UP London | British | 47537030001 | ||||||
COPE, Nigel Leslie | Secrétaire | 119 Burnham Lane SL1 6LA Burnham Berkshire | British | Marketing Director | 97685670001 | |||||
COPE, Nigel Leslie | Secrétaire | 129 Mortlake Road Kew TW9 4AW Richmond Surrey | British | 13511870001 | ||||||
DAY, Simon Philip | Secrétaire | 23 Ash Green Great Chesterford CB10 1QR Saffron Walden Essex | British | 71393050001 | ||||||
FEERY, Stephen Joseph | Secrétaire | 131 Chalklands SL8 5TL Bourne End Buckinghamshire | British | 21558970001 | ||||||
ARMITAGE, Timothy Peter | Administrateur | Sandford Barn Sandford Lane Woodley RG5 4TB Reading Berkshire | United Kingdom | British | Director | 49179200001 | ||||
CHAPMAN, Paul George | Administrateur | Rosebank 4 Shortsill Lane Flaxby HG5 0RT Knaresborough North Yorkshire | England | British | Director | 24182580002 | ||||
COPE, Nigel Leslie | Administrateur | 11 St Laurence Way SL1 2EA Slough The Coins Building Berkshire England | United Arab Emirates | British | Company Director | 97685670004 | ||||
FEERY, Stephen Joseph | Administrateur | 131 Chalklands SL8 5TL Bourne End Buckinghamshire | British | Company Director | 21558970001 | |||||
GAY, Andrew | Administrateur | Bircham Dyson Bell 50 Broadway SW1H 0BL London | United Kingdom | British | Company Director | 73774260004 | ||||
JACKSON, George Barry | Administrateur | Willow Cottage Church Lane Boxgrove PO18 0ED Chichester West Sussex | England | British | Director | 24677720001 | ||||
JAMES, Michael Timothy | Administrateur | 11 St Laurence Way SL1 2EA Slough The Coins Building Berkshire England | England | British | Company Director | 114453240001 | ||||
LEAVER, Derek | Administrateur | 11 St Laurence Way SL1 2EA Slough The Coins Building Berkshire England | England | British | Director | 58541610002 | ||||
LIDGATE, Stephen Robert | Administrateur | The Coins Building 12 The Grove SL1 1QP Slough Berkshire | England | British | Company Director | 103537740001 | ||||
MORLEY, Sean Maurice Hill | Administrateur | 143 Percy Road TW12 2JP Hampton Middlesex | British | Project Manager | 77050730003 | |||||
OBRIEN, David | Administrateur | Copyhold Chertsey Road GU24 8HS Chobham Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 6759900001 | ||||
SHAW, Laurence David | Administrateur | 11 St Laurence Way SL1 2EA Slough The Coins Building Berkshire England | England | British | British | 4482600002 | ||||
SKINNER, Gordon William Ford | Administrateur | Bayshill House Templewood Park Templewood Lane SL2 4DA Slough | England | British | Director | 150542080001 | ||||
SMITH, Colin | Administrateur | 7 Iver Lodge Bangors Road South SL0 0AW Iver Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 70557860003 | ||||
SWANSON, Thomas Hillis | Administrateur | Tigh Na Bruaich Laigh Braehead Braehead Road Thorntonhall G74 5AQ Glasgow | United Kingdom | British | Company Director | 86147070001 | ||||
WERNER, Richard Louis | Administrateur | 11 St Laurence Way SL1 2EA Slough The Coins Building Berkshire England | United States | American | Executive | 121290680001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CSB HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Lawrence John Sullivan | 06 avr. 2016 | Caroline Street B3 1UP Birmingham 79 | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
|
CSB HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 26 juil. 2007 Livré le 06 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 mai 2003 Livré le 30 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 21 déc. 1994 Livré le 21 déc. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee an debenture | Créé le 14 sept. 1994 Livré le 30 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 01 févr. 1994 Livré le 04 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CSB HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0