MH VOKES AIR UK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MH VOKES AIR UK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02400211 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MH VOKES AIR UK LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MH VOKES AIR UK LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quels sont les derniers dépôts pour MH VOKES AIR UK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de George Henry Black en tant que directeur le 23 févr. 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Divers Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED | 1 pages | MISC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 4 pages | AC92 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16 | pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 12 oct. 2014 | 16 pages | RP04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 15 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 16 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Nomination de Steffen Schneider en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Blomqvist en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Blomqvist en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 16 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur George Henry Black le 19 oct. 2013 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur George Henry Black le 19 oct. 2012 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MH VOKES AIR UK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Steffen | Administrateur | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | Germany | German | 185882550001 | |||||
| BLOMQVIST, Thomas | Secrétaire | Stureparken 11 4th Floor Stockholm 114 26 Sweden | Swedish | 132005410001 | ||||||
| SOHAL, Balkar | Secrétaire | 5 North Park NG18 4PA Mansfield Nottinghamshire | British | 122186580001 | ||||||
| M.R. SERVICES LIMITED | Secrétaire | C/O Vokes-Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | 55567600012 | |||||||
| MR SERVICES LIMITED | Secrétaire | Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way Abingdon Business Park OX14 1RG Abingdon Oxfordshire | 55567600003 | |||||||
| WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Suite Two Hitching Court Blacklands Way Abingdon Business Par OX14 1RG Abingdon Oxfordshire | 39955810002 | |||||||
| BLACK, George Henry | Administrateur | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | Uk | British | 151256750002 | |||||
| BLOMQVIST, Thomas | Administrateur | Stureparken 11 4th Floor Stockholm 114 26 Sweden | Swedish | 132005410001 | ||||||
| BOSWELL, Brian Peter | Administrateur | Garden Cottage Hawford House Hawford WR3 7SQ Worcester Worcestershire | British | 52804120001 | ||||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Administrateur | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| COLE, Ian Robert | Administrateur | 4 Knarsdale Close Lakeside DY5 3RF Brierley Hill West Midlands | British | 42980510001 | ||||||
| COTTON, Richard John | Administrateur | 148 Myton Road CV34 6PR Warwick | England | British | 45397090001 | |||||
| DOHERTY, James Patrick | Administrateur | 950 S E 82nd Street Road Ocala Florida 34480 | Irish | 105328280001 | ||||||
| FERRARI, Fabio | Administrateur | Lot Chirouzanches 05240 La Salle Les Alps France | French | 132005120001 | ||||||
| FITCHFORD, Andrew Michael John | Administrateur | The Old House The Green B94 5AJ Tanworth In Arden Warwickshire | British | 99141670001 | ||||||
| FROY, Robert Anthony Douglas | Administrateur | 171 Defoe House Barbican EC2Y 8ND London | British | 35373020004 | ||||||
| GOPSILL, Michael Clement | Administrateur | Wood Cottage Norton Road Iverley Stourbridge West Midlands | British | 32481900001 | ||||||
| HAZLEHURST, Ian James | Administrateur | Malvern Park Farm Widney Manor Road B91 3JG Solihull West Midlands | British | 43476760001 | ||||||
| HODGSON, Geoffrey Phillip | Administrateur | Canterbury Cottage Fox Pond Lane LE2 4RY Great Glen Leicestershire | British | 107483910001 | ||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Administrateur | The Wendy House 3 Elf Meadow Poulton GL7 5HQ Cirencester Gloucestershire | British | 33223550001 | ||||||
| JONES, Alan Martin | Administrateur | 5 Firsway Wightwick WV6 8BJ Wolverhampton West Midlands | British | 47891670001 | ||||||
| KEARNEY, Christopher James | Administrateur | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LADENBERGER, Daniel Timothy | Administrateur | 24 Portland Place Saint Louis Missouri 63108 Usa | American | 110032170001 | ||||||
| LEEK, James Anthony | Administrateur | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Administrateur | 13515 Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 110636870001 | |||||
| MCGOWAN, John Peter | Administrateur | Lantern House Abbotswood WR11 4NS Evesham Worcestershire | British | 62509010002 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Administrateur | 6524 Chipstead Lane 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PETERSON, Andris | Administrateur | Redlands Lower Town WR3 7RY Claines Worcestershire | American | 31642760001 | ||||||
| RADISCH, Klaus Ingo | Administrateur | Weidendstrasse 36 Sonsbeck 47665 Germany | Germany | German | 121578410001 | |||||
| REILLY, Michael Andrew | Administrateur | 2007 Channelstone Way NC 28104 Matthews Nc 28104 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||
| RENZI, Anthony Andrew | Administrateur | 5101 Sw 60th Street Road Ocala Florida 34474 Usa | American | 121578380001 | ||||||
| WALKER, Craig Allen | Administrateur | Bruhnstrasse 2a FOREIGN 40225 Dusseldorf Germany | Usa | 109340980001 | ||||||
| WINOWIECKI, Ronald Lee | Administrateur | 8707 Calumet Farms Drive Wexham Nc 28173 Usa | American | 95572300001 |
MH VOKES AIR UK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Créé le 22 févr. 1993 Livré le 09 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed | |
Brèves mentions All moneys,dividends and interest in respect of the shares. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Share pledge agreement | Créé le 18 janv. 1993 Livré le 02 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined) | |
Brèves mentions By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage of shares | Créé le 18 janv. 1993 Livré le 02 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them | |
Brèves mentions All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge agreement | Créé le 18 janv. 1993 Livré le 02 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92 | |
Brèves mentions The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge agreement | Créé le 18 janv. 1993 Livré le 02 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92 | |
Brèves mentions 25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 22 déc. 1992 Livré le 07 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them | |
Brèves mentions See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0