MH VOKES AIR UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMH VOKES AIR UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02400211
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MH VOKES AIR UK LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MH VOKES AIR UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MH VOKES AIR UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VOKES AIR UK LIMITED26 août 200826 août 2008
    SPX VOKES LIMITED13 janv. 200613 janv. 2006
    MCLEOD RUSSEL INTERNATIONAL LIMITED03 août 199803 août 1998
    WHEWAY INTERNATIONAL LIMITED15 août 198915 août 1989
    VOWDIN LIMITED03 juil. 198903 juil. 1989

    Quels sont les derniers comptes de MH VOKES AIR UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour MH VOKES AIR UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de George Henry Black en tant que directeur le 23 févr. 2017

    2 pagesTM01

    Divers

    Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED
    1 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Certificat de changement de nom

    Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16
    pagesCERTNM
    Annotations
    DateAnnotation
    09 nov. 2016Clarification changed its name on 04/11/2016 to MH VOKES AIR UK LIMITED and not the name MH VOKES AIR UK LIMITED LIMITED as incorrectly shown on the face of the certificate of change of name issued on that date.

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 12 oct. 2014

    16 pagesRP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 oct. 2014

    État du capital au 21 oct. 2014

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    11 nov. 2014Clarification A second filed AR01 was registered on 11/11/2014

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    16 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name28 mars 2014

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Steffen Schneider en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Blomqvist en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Thomas Blomqvist en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur George Henry Black le 19 oct. 2013

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 oct. 2013

    État du capital au 18 oct. 2013

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur George Henry Black le 19 oct. 2012

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de MH VOKES AIR UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCHNEIDER, Steffen
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    GermanyGerman185882550001
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Secrétaire
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Secrétaire
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BLACK, George Henry
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    UkBritish151256750002
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Administrateur
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    British52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Administrateur
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Administrateur
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Administrateur
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Administrateur
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FERRARI, Fabio
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    Administrateur
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    French132005120001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    FROY, Robert Anthony Douglas
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    Administrateur
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    British35373020004
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    British32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HODGSON, Geoffrey Phillip
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    Administrateur
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    British107483910001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    British47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Administrateur
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Administrateur
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Administrateur
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Administrateur
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Administrateur
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    PETERSON, Andris
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    Administrateur
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    American31642760001
    RADISCH, Klaus Ingo
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    Administrateur
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    GermanyGerman121578410001
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Administrateur
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    RENZI, Anthony Andrew
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    Administrateur
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    American121578380001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Administrateur
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Administrateur
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    MH VOKES AIR UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed
    Créé le 22 févr. 1993
    Livré le 09 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed
    Brèves mentions
    All moneys,dividends and interest in respect of the shares.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transactions
    • 09 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share pledge agreement
    Créé le 18 janv. 1993
    Livré le 02 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined)
    Brèves mentions
    By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcthe "Pledgees" (As Defined)
    Transactions
    • 02 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of shares
    Créé le 18 janv. 1993
    Livré le 02 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 02 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 18 janv. 1993
    Livré le 02 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92
    Brèves mentions
    The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transactions
    • 02 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 18 janv. 1993
    Livré le 02 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92
    Brèves mentions
    25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transactions
    • 02 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 déc. 1992
    Livré le 07 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them
    Brèves mentions
    See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transactions
    • 07 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0