PAYHOT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PAYHOT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02401163 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PAYHOT LIMITED ?
Adresse du siège social | Avis Budget House Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire England England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PAYHOT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour PAYHOT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 12 nov. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Edward Rollason le 26 mars 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Inderpal Lall en tant que secrétaire le 20 juil. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Gail Marion Jones en tant que secrétaire le 20 juil. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 7 Welbeck Street London W1G 9YE à Avis Budget House Park Road Bracknell, Berkshire England RG12 2EW le 10 nov. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Broughton Secretaries Limited en tant que secrétaire le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Edward Rollason en tant qu'administrateur le 30 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Joanna Elizabeth Spiers en tant que directeur le 30 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de PAYHOT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALL, Inderpal | Secrétaire | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 248830140001 | |||||||||||
FORD, Paul Leslie | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 197045450001 | ||||||||
ROLLASON, Paul Edward | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 168157490002 | ||||||||
JONES, Gail Marion | Secrétaire | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 177025120001 | |||||||||||
NICHOLSON, Judith Ann | Secrétaire | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks England | British | 27201530002 | ||||||||||
BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
BELL, Nina Anne | Administrateur | 11 The Burlings SL5 8BY Ascot Berkshire | England | British | Accountant | 99807710003 | ||||||||
CATHCART, William Alun | Administrateur | Robin Rag The Common GU6 8SH Cranleigh Surrey | British | Company Director | 9490580007 | |||||||||
COATES, Richard John | Administrateur | 7 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Bucks | British | Vice President | 81363010001 | |||||||||
COWAN, Christopher Ian | Administrateur | Ballards Ballards Lane RH8 0SN Limpsfield Surrey | British | Group Finance Director | 54679190001 | |||||||||
DAX, William Airlie | Administrateur | The Old Post Office Village Road Dorney SL4 6QW Windsor Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 92201720001 | ||||||||
FILLINGHAM, Stuart Barry David | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | England | British | Accountant | 99807720001 | ||||||||
FORD, Paul Leslie | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 45288050004 | ||||||||
GATES, Edwin Peter | Administrateur | Westcott 5 Millhedge Close KT11 3BE Cobham Surrey | United Kingdom | British | Vice President-Treasury | 38944950001 | ||||||||
HANNA, Kenneth George | Administrateur | 5 Onslow Drive Ascot Mansions SL5 7UL North Ascot Berkshire | British | Company Director | 78515410001 | |||||||||
MALONEY, David Ossian | Administrateur | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 69071800002 | ||||||||
MCCAFFERTY, Mark | Administrateur | 39 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive | 61788610002 | ||||||||
NICHOLSON, Judith Ann | Administrateur | Alkerden Road W4 2HP London 15 United Kingdom | England | British | Company Secretary | 27201530002 | ||||||||
SACHDEVA, Rajiv | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 169861260001 | ||||||||
SMITH, Martyn Robert | Administrateur | 61 Esmond Road W4 1JE London | England | British | Accountant | 100650660001 | ||||||||
SPIERS, Joanna Elizabeth | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 178651670001 | ||||||||
TURNER, Jason Christopher Godsell | Administrateur | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 135757770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PAYHOT LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avis Europe Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PAYHOT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Créé le 26 mars 1997 Livré le 10 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti Each and every liability which the obligors (as defined therein) have to the chargee (for itself and for the beneficiaries (as defined)) under or pursuant to the facility documents (as defined) | |
Brèves mentions All right title and interest in the relevant shares together with all dividends, interest and other monies payable thereon and all stocks, shares, warrants, securities, money or property accruing thereunder by way of redemption, purchase or bonus etc.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge | Créé le 11 août 1992 Livré le 18 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the facility documents the consortium documents and/or the deed of charge of even date | |
Brèves mentions Fixed charge over all the estates rights and other interests in f/h property and l/h proprty (a) having a term of more than 25 years unexpired at the date of liquidation or (b) of whatever term if the value attributable thereto see 395 5L l 20/8 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 07 août 1992 Livré le 21 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions See form 395 ref M103. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A deed of debenture | Créé le 03 août 1990 Livré le 15 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to any of the facility documents or any of the consortium documents as defined in this deed. | |
Brèves mentions (See 395 ref M207 and cont'd sheets for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0