MIDMINT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMIDMINT LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02402708
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MIDMINT LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MIDMINT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    14 Bonhill Street
    EC2A 4BX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MIDMINT LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2017
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2017

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MIDMINT LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 juil. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 juil. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 juil. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour MIDMINT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2024

    10 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor Allan House 10 John Princess Street London W1G 0AH à 14 Bonhill Street London EC2A 4BX le 27 avr. 2024

    3 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2023

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2022

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2021

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2020

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2019

    11 pagesLIQ03

    Satisfaction de la charge 024027080019 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Wellington House Cliffe Park Bruntcliffe Road Morley Leeds West Yorkshire LS27 0RY à 4th Floor Allan House 10 John Princess Street London W1G 0AH le 31 juil. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 juil. 2018

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 024027080017 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 024027080018 en totalité

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 024027080019, créée le 20 déc. 2017

    105 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 024027080016 en totalité

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 024027080018, créée le 27 sept. 2017

    100 pagesMR01

    Nomination de Mr Manish Mansukhlal Gudka en tant qu'administrateur le 27 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gareth Jones en tant qu'administrateur le 27 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Edward Purtill en tant que directeur le 27 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Don Goulding en tant que directeur le 27 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Don Goulding en tant que secrétaire le 27 sept. 2017

    1 pagesTM02

    Inscription de la charge 024027080017, créée le 27 sept. 2017

    100 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de MIDMINT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Administrateur
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    United KingdomBritishCompany Director163227370001
    JONES, Gareth
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Administrateur
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    EnglandBritishChartered Accountant121225470001
    GOULDING, Ian Don
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    Secrétaire
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    BritishDirector39828490004
    KELLY, Anthony Brian
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    Secrétaire
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    BritishAccountant66203340002
    MILLS, Ronald Charles
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    Secrétaire
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    BritishAccountant2836970002
    PARTAKIS-STEVENS, Georgina Hellene
    The Laurels
    15 Fletsand Road
    SK9 2AD Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    The Laurels
    15 Fletsand Road
    SK9 2AD Wilmslow
    Cheshire
    British16578680001
    ACKERMAN, Stephen Carl
    The Cottage
    Shenfield Green
    CM15 8NG Shenfield
    Essex
    Administrateur
    The Cottage
    Shenfield Green
    CM15 8NG Shenfield
    Essex
    EnglandBritishInvestment Director154539780001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishSolicitor122926460001
    CROMPTON, Robert Morton
    66 Eatock Way
    Westhoughton
    BL5 2RR Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    66 Eatock Way
    Westhoughton
    BL5 2RR Bolton
    Lancashire
    BritishDirector16578690001
    CROMPTON, Robert Morton
    66 Eatock Way
    Westhoughton
    BL5 2RR Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    66 Eatock Way
    Westhoughton
    BL5 2RR Bolton
    Lancashire
    BritishAccountant16578690001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBanker68241910003
    DICKSON, Pamela Simone
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    Administrateur
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    United KingdomScottishBanker91810830001
    EYLES, Peter George
    Cross Oak House
    Cross Oak Lane
    RH1 5RF Redhill
    Surrey
    Administrateur
    Cross Oak House
    Cross Oak Lane
    RH1 5RF Redhill
    Surrey
    United KingdomBritishDirector98648030001
    GOULDING, Ian Don
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    Administrateur
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    EnglandBritishDirector39828490044
    KELLY, Anthony Brian
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    BritishAccountant66203340002
    MILLS, Ronald Charles
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    Administrateur
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    United KingdomBritishAccountant2836970002
    PARTAKIS, Elsie
    Holly Bank Farm
    SK9 4LT Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Holly Bank Farm
    SK9 4LT Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director16578710001
    PARTAKIS, George
    Hollybank Farm Altrincham Road
    SK9 4LT Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Hollybank Farm Altrincham Road
    SK9 4LT Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director16578700001
    PARTAKIS, Michael Georgiou
    Edenfield One Oak Lane
    SK9 2BL Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Edenfield One Oak Lane
    SK9 2BL Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director11234990001
    PARTAKIS-STEVENS, Georgina Hellene
    The Laurels
    15 Fletsand Road
    SK9 2AD Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    The Laurels
    15 Fletsand Road
    SK9 2AD Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director16578680001
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Administrateur
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrishDirector7856280001
    TAYLOR, David James
    18 Spencers Way
    HG1 3DN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    18 Spencers Way
    HG1 3DN Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector88020060001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MIDMINT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Devonshire Point S.A.R.L
    Rue Lou Hemmer
    L-1748 Findel
    4
    Luxembourg
    06 avr. 2016
    Rue Lou Hemmer
    L-1748 Findel
    4
    Luxembourg
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementLuxembourg
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementRegistre De Commerce Et Des Societes
    Numéro d'enregistrementB185413
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Wellington House
    England
    06 avr. 2016
    Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Wellington House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4683806
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    MIDMINT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 déc. 2017
    Livré le 21 déc. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 21 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 sept. 2017
    Livré le 04 oct. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 04 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 sept. 2017
    Livré le 03 oct. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 03 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 avr. 2016
    Livré le 20 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 20 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Loan Solutions LLP (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A third composite guarantee and debenture
    Créé le 13 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any principal debtor to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a the queens hotel city square leeds t/no wyk 316711, f/h property k/a le meridien warwick kenilworth road warwick t/no wk 283205, f/h property k/a east and west spinneys wooton hill wooton t/no wk 380830 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share charge
    Créé le 16 févr. 2005
    Livré le 03 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee (and/or the hedging counterparty) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The investments.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 03 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 févr. 2005
    Livré le 03 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee (and/or the hedging counterparty) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 03 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 16 févr. 2005
    Livré le 28 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any principal debtor to the security trustee (as agent and trustee for the noteholders) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 16 févr. 2005
    Livré le 28 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any principal debtor to the security trustee (as agent and trustee for the noteholders) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 07 mars 2001
    Livré le 22 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property the park royal international hotel, stretton road, stretton, warrington. T/no. CH340902, f/h north wiew, stretton road, stretton, warrington. T/no. CH272703, f/h land on the south side of stretton road, warrington. T/no.CH406425. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thesecured Parties
    Transactions
    • 22 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 août 1998
    Livré le 11 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h and l/h land k/a 1-5 stretton road stretton warrington t/nos.CH415160 CH255254 CH364457 CH332917 & CH151324. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 27 nov. 1992
    Livré le 02 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £290,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee or its nominated subsidiary or associated companies in respect of goods supplied.
    Brèves mentions
    All that f/h land situate and k/a the old vicarage hotel stretton road stretton warrington cheshire.t/no.ch 340902.all and every of the company's fixed and moveable plant equipment furniture fixtures and fittings.the goodwill of the business and the full benefit of all licences.please see doc M12C for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tetley Walker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 1991
    Livré le 30 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 03 sept. 1991
    Livré le 14 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 acres of land or thereabouts on the east side of northwich road, stretton nr warrington cheshire. The benefit of all covenants and rights affecting the property. The plant machinery, fixtures & fittings, furniture, equipment, implements and utensils. The present and future goodwill of any business of a licensed publican, hotelier or restaurateur, the benefit of all justices, excise or other licences.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 1991
    Livré le 14 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 03 sept. 1991
    Livré le 14 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Old vicarage hotel, stretton road, stretton, near warrington cheshire. The benefit of all covenants and rights affecting the property. The plant, machinery fixtures & fittings, furniture, equipment, implements and utensils the present & future goodwill of any business of a licensed publican, hotelier or restaurateur. The benefit of all justices, excise or other licences.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1991
    Livré le 17 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Field view northwich road (sparkhall close) stretton warrington title no ch 254861 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment and the benefit of all covenants and rights affecting or concerining the property described.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 mai 1991
    Livré le 05 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and building k/as "northview" stretton road, stretton, warrington. Title no. Ch 272703 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 22 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MIDMINT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 juil. 2018Commencement of winding up
    12 juil. 2018Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony Harry Hyams
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London
    practitioner
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0