OXYGEN SOLUTIONS LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | OXYGEN SOLUTIONS LTD |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02405625 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe OXYGEN SOLUTIONS LTD ?
Adresse du siège social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de OXYGEN SOLUTIONS LTD ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour OXYGEN SOLUTIONS LTD ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
legacy | 207 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 2 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanne Sarah Finch en tant que directeur le 26 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 18 août 2014 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patrick Dawe-Lane en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Nomination de Mr David Nigel Evans en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Purkess en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de OXYGEN SOLUTIONS LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
EVANS, David Nigel | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 134975040001 | ||||||||
MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 173703620001 | ||||||||
BAKER, Susan Elizabeth | Secrétaire | Flat 4 47 Maresfield Gardens Hampstead NW3 5TE London | British | 42538140002 | ||||||||||
BANWELL, Michael John | Secrétaire | Evadene Hogs Lodge Lane, Buster Hill PO8 0QA Waterlooville Hampshire | British | 84802540001 | ||||||||||
BARKER, Simon | Secrétaire | 10 Alexandra Road Englefield Green TW20 0RP Egham Surrey | British | 13710830003 | ||||||||||
BARKER, Simon | Secrétaire | 10 Alexandra Road Englefield Green TW20 0RP Egham Surrey | British | 13710830003 | ||||||||||
DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Secrétaire | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||||||
EMETULU, Lola | Secrétaire | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
HOWIE, Philip Robert Sutherland | Secrétaire | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||||||
KLINGER, Paul | Secrétaire | Les Godaines George Road St Peter Port GY1 1BD Guernsey Channel Islands | British | Solicitor | 106221780001 | |||||||||
AZIZ, Javaid Khurshid, Dr | Administrateur | Larksmead Titlarks Hill SL5 0JD Ascot Berkshire | England | English | Director | 68624410001 | ||||||||
BANWELL, Michael John | Administrateur | Evadene Hogs Lodge Lane, Buster Hill PO8 0QA Waterlooville Hampshire | England | British | Accountant | 84802540001 | ||||||||
BARKER, Simon | Administrateur | 10 Alexandra Road Englefield Green TW20 0RP Egham Surrey | British | Marketing Consultant | 13710830003 | |||||||||
CARRATT, David Jonathan | Administrateur | Glenridge Lodge Callow Hill GU25 4LF Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | Investment Manager | 22585710002 | ||||||||
DANNATT, Gary John | Administrateur | 13 College Ride GU19 5EW Bagshot Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 210840150001 | ||||||||
EAST, Richard Quentin | Administrateur | 8 Gipsy Lane SW15 5RG London | British | Operator | 14278130001 | |||||||||
EVANS, Mark | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Chief Financial Officer | 127017870001 | |||||||||
FINCH, Joanne Sarah | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Senior Finance Manager | 158146620001 | ||||||||
HARRIS, Brian Athol | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | Australian | Head Of Enterprise Finance | 135937300001 | ||||||||
HONE, Thomas Nathaniel | Administrateur | Brand Lodge Upper Colwall WR13 6DW Malvern Worcester | British | Company Director | 57901470001 | |||||||||
LEE, Simon Christopher | Administrateur | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
MEYER, Charles Henry Robin | Administrateur | Holford Manor North Chailey BN8 4DU Lewes East Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 48074280001 | ||||||||
MYERS, Andrew | Administrateur | 18 Chilton Road TW9 4JB Richmond Surrey | British | Company Director | 13710840002 | |||||||||
NASH, Jo | Administrateur | 40 Burrows Road NW10 5SG London | British | Human Resources | 74979690002 | |||||||||
NOWAK, Thomas, Dr | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | Director | 174443800001 | ||||||||
PATERSON, John Alastair Cleland | Administrateur | Lyfords Iping Road Milland GU30 7NA Liphook Hampshire | British | Director Software Company | 12952940003 | |||||||||
PENNY, Stuart | Administrateur | Wildwood 8 Brock Way GU254SD Virginia Water Surrey | British | Director | 13710860002 | |||||||||
PURKESS, Martin John | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | Director | 139360020001 | ||||||||
READ, Nicholas Jonathan | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 87149560001 | ||||||||
RICHARDSON, Philip John | Administrateur | 57 Turpins Rise GU20 6NQ Windlesham Surrey | British | Sales & Marketing Director | 48635420001 | |||||||||
SCHA*FER, Richard Wolfgang Henry | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance Technology & Support | 150941520001 | ||||||||
SEARS, Michael | Administrateur | 103 Devonshire Mews South W1G 6QS London | United Kingdom | British | Company Director | 35557430001 | ||||||||
TOURNON, Emanuele | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | Director | 103542080002 | ||||||||
WEBB, Denys William | Administrateur | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | Director | 76074580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OXYGEN SOLUTIONS LTD ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspective Limited | 06 avr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
OXYGEN SOLUTIONS LTD a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Créé le 31 oct. 1997 Livré le 14 nov. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti The rents reserved by and the other sums payable under the lease made between the company and bankers trust company | |
Brèves mentions The company's right,title and interest in the "rent deposit" (as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 mai 1995 Livré le 20 mai 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti £360,000 due from the company to the chargee under the terms of this debenture | |
Brèves mentions Fixed equitable charge over all estates or interest on any f/h or l/h property now or at any time belonging to the company. Fixed charge over all stocks shares or other securities now or at any time belonging to the company. Fixed charge over its goodwill. Fixed charge over all book and other debts now or at any time owing to the company. Floating charge over its undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever situate present and future (including its uncalled capital). Legal charge over the software systems, source codes and intellectual property held on disk or otherwise. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 mai 1995 Livré le 20 mai 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti £40,000 due from the company to the chargee under the terms of this debenture | |
Brèves mentions Fixed equitable charge over all estates or interest on any f/h or l/h property now or at any time belonging to the company. Fixed charge over all stocks shares or other secuirites now or at any time belonging to the company.fixed charge over its goodwill. Fixed charge over all book and other debts now or at any time owing to the company. Floating charge over its undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever situate present and future (including its uncalled capital). Legal charge over software systems, source codes and intellectual property of the company on disk or otherwise. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 14 oct. 1994 Livré le 19 oct. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0