OXYGEN SOLUTIONS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOXYGEN SOLUTIONS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02405625
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTEGRATED SALES SYSTEMS U.K. LIMITED27 oct. 199727 oct. 1997
    INTEGRATED SALES SYSTEMS LIMITED18 juil. 198918 juil. 1989

    Quels sont les derniers comptes de OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2016

    8 pagesAA

    legacy

    207 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 pagesAD04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2015

    État du capital au 09 déc. 2015

    • Capital: GBP 1,018,302.3
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 nov. 2014

    État du capital au 27 nov. 2014

    • Capital: GBP 1,018,302.3
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Joanne Sarah Finch en tant que directeur le 26 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 18 août 2014

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Patrick Dawe-Lane en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 nov. 2013

    État du capital au 08 nov. 2013

    • Capital: GBP 1,018,302.3
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr David Nigel Evans en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Purkess en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    BAKER, Susan Elizabeth
    Flat 4 47 Maresfield Gardens
    Hampstead
    NW3 5TE London
    Secrétaire
    Flat 4 47 Maresfield Gardens
    Hampstead
    NW3 5TE London
    British42538140002
    BANWELL, Michael John
    Evadene
    Hogs Lodge Lane, Buster Hill
    PO8 0QA Waterlooville
    Hampshire
    Secrétaire
    Evadene
    Hogs Lodge Lane, Buster Hill
    PO8 0QA Waterlooville
    Hampshire
    British84802540001
    BARKER, Simon
    10 Alexandra Road
    Englefield Green
    TW20 0RP Egham
    Surrey
    Secrétaire
    10 Alexandra Road
    Englefield Green
    TW20 0RP Egham
    Surrey
    British13710830003
    BARKER, Simon
    10 Alexandra Road
    Englefield Green
    TW20 0RP Egham
    Surrey
    Secrétaire
    10 Alexandra Road
    Englefield Green
    TW20 0RP Egham
    Surrey
    British13710830003
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Secrétaire
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    KLINGER, Paul
    Les Godaines
    George Road St Peter Port
    GY1 1BD Guernsey
    Channel Islands
    Secrétaire
    Les Godaines
    George Road St Peter Port
    GY1 1BD Guernsey
    Channel Islands
    BritishSolicitor106221780001
    AZIZ, Javaid Khurshid, Dr
    Larksmead
    Titlarks Hill
    SL5 0JD Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Larksmead
    Titlarks Hill
    SL5 0JD Ascot
    Berkshire
    EnglandEnglishDirector68624410001
    BANWELL, Michael John
    Evadene
    Hogs Lodge Lane, Buster Hill
    PO8 0QA Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Evadene
    Hogs Lodge Lane, Buster Hill
    PO8 0QA Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant84802540001
    BARKER, Simon
    10 Alexandra Road
    Englefield Green
    TW20 0RP Egham
    Surrey
    Administrateur
    10 Alexandra Road
    Englefield Green
    TW20 0RP Egham
    Surrey
    BritishMarketing Consultant13710830003
    CARRATT, David Jonathan
    Glenridge Lodge Callow Hill
    GU25 4LF Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Glenridge Lodge Callow Hill
    GU25 4LF Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Manager22585710002
    DANNATT, Gary John
    13 College Ride
    GU19 5EW Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    13 College Ride
    GU19 5EW Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant210840150001
    EAST, Richard Quentin
    8 Gipsy Lane
    SW15 5RG London
    Administrateur
    8 Gipsy Lane
    SW15 5RG London
    BritishOperator14278130001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    HARRIS, Brian Athol
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)AustralianHead Of Enterprise Finance135937300001
    HONE, Thomas Nathaniel
    Brand Lodge
    Upper Colwall
    WR13 6DW Malvern
    Worcester
    Administrateur
    Brand Lodge
    Upper Colwall
    WR13 6DW Malvern
    Worcester
    BritishCompany Director57901470001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MEYER, Charles Henry Robin
    Holford Manor
    North Chailey
    BN8 4DU Lewes
    East Sussex
    Administrateur
    Holford Manor
    North Chailey
    BN8 4DU Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director48074280001
    MYERS, Andrew
    18 Chilton Road
    TW9 4JB Richmond
    Surrey
    Administrateur
    18 Chilton Road
    TW9 4JB Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director13710840002
    NASH, Jo
    40 Burrows Road
    NW10 5SG London
    Administrateur
    40 Burrows Road
    NW10 5SG London
    BritishHuman Resources74979690002
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PATERSON, John Alastair Cleland
    Lyfords Iping Road
    Milland
    GU30 7NA Liphook
    Hampshire
    Administrateur
    Lyfords Iping Road
    Milland
    GU30 7NA Liphook
    Hampshire
    BritishDirector Software Company12952940003
    PENNY, Stuart
    Wildwood
    8 Brock Way
    GU254SD Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Wildwood
    8 Brock Way
    GU254SD Virginia Water
    Surrey
    BritishDirector13710860002
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director87149560001
    RICHARDSON, Philip John
    57 Turpins Rise
    GU20 6NQ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    57 Turpins Rise
    GU20 6NQ Windlesham
    Surrey
    BritishSales & Marketing Director48635420001
    SCHA*FER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support150941520001
    SEARS, Michael
    103 Devonshire Mews South
    W1G 6QS London
    Administrateur
    103 Devonshire Mews South
    W1G 6QS London
    United KingdomBritishCompany Director35557430001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianDirector103542080002
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector76074580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OXYGEN SOLUTIONS LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3866545
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    OXYGEN SOLUTIONS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 31 oct. 1997
    Livré le 14 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The rents reserved by and the other sums payable under the lease made between the company and bankers trust company
    Brèves mentions
    The company's right,title and interest in the "rent deposit" (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company
    Transactions
    • 14 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mai 1995
    Livré le 20 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £360,000 due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge over all estates or interest on any f/h or l/h property now or at any time belonging to the company. Fixed charge over all stocks shares or other securities now or at any time belonging to the company. Fixed charge over its goodwill. Fixed charge over all book and other debts now or at any time owing to the company. Floating charge over its undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever situate present and future (including its uncalled capital). Legal charge over the software systems, source codes and intellectual property held on disk or otherwise.
    Personnes ayant droit
    • Fenchurch Trust Limited
    Transactions
    • 20 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mai 1995
    Livré le 20 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge over all estates or interest on any f/h or l/h property now or at any time belonging to the company. Fixed charge over all stocks shares or other secuirites now or at any time belonging to the company.fixed charge over its goodwill. Fixed charge over all book and other debts now or at any time owing to the company. Floating charge over its undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever situate present and future (including its uncalled capital). Legal charge over software systems, source codes and intellectual property of the company on disk or otherwise.
    Personnes ayant droit
    • Search Investments PLC
    Transactions
    • 20 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 oct. 1994
    Livré le 19 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0