NITRIDING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNITRIDING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02406009
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NITRIDING SERVICES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe NITRIDING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NITRIDING SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THERMO CHEMICAL TREATMENTS LIMITED07 nov. 198907 nov. 1989
    INGLEBY (429) LIMITED19 juil. 198919 juil. 1989

    Quels sont les derniers comptes de NITRIDING SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour NITRIDING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 janv. 2011

    État du capital au 24 janv. 2011

    • Capital: GBP 544,400.02
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Miss Denise Osborn en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Nicholas Duncalf en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Nicholas Duncalf en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Dell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288a
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 18/03/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2004

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2003

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NITRIDING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OSBORN, Denise
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    Secrétaire
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    146124880001
    JAEGER, Oliver
    Mettmann
    Germany
    Administrateur
    Mettmann
    Germany
    GermanyGerman138189510001
    ASHTON, David John
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    Secrétaire
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    British24459630003
    DUNCALF, Nicholas John
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British148208420001
    KNIGHTS, John Ivan
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    British126545670001
    POLLAK, David Arthur
    40 The Gardens
    WD17 3DW Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    40 The Gardens
    WD17 3DW Watford
    Hertfordshire
    British64234590001
    ASHTON, David John
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    Administrateur
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    EnglandBritish24459630003
    BACON, Nicholas Andrew William
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish159081540001
    BAUMANN, Christopher John
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    Administrateur
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish102220130001
    BUSTER, Richard Geoffrey
    58 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HQ Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    58 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HQ Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish4325580001
    DELL, Stephen John
    55 Bucklow Gardens
    WA13 9RN Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    55 Bucklow Gardens
    WA13 9RN Lymm
    Cheshire
    British124021740001
    DUNCALF, Nicholas John
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish148208420001
    EALES, Darryl Charles
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish2886080001
    HEAP, William John
    Alameda Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Alameda Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    British24459640001
    KNIGHTS, John Ivan
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    British126545670001
    LEEK, Peter William
    Tintagel 119 Broad Lane
    WV3 9BP Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Tintagel 119 Broad Lane
    WV3 9BP Wolverhampton
    West Midlands
    British10939100001
    LEEKE, Graham Maurice
    The Grove
    Tachbrook Mallory
    CV33 9QE Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    The Grove
    Tachbrook Mallory
    CV33 9QE Leamington Spa
    Warwickshire
    British29510450001
    ROBINSON, Kevin
    34 Winster Avenue
    Dorridge
    B93 8ST Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    34 Winster Avenue
    Dorridge
    B93 8ST Solihull
    West Midlands
    British61267640001
    SHARP, Keith
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    Administrateur
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    EnglandBritish77395770001
    STAINES, Anthony Martin, Doctor
    10 Carmichael Close
    WS14 9YW Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    10 Carmichael Close
    WS14 9YW Lichfield
    Staffordshire
    British57218330001

    NITRIDING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 févr. 1999
    Livré le 27 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 27 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rental deposit
    Créé le 06 nov. 1997
    Livré le 08 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 together with interest thereon due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit of £40,000.
    Personnes ayant droit
    • Lilden Properties Limited
    Transactions
    • 08 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 26 sept. 1995
    Livré le 17 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 15 february 1994 or under the chattel mortgage
    Brèves mentions
    Nitrex gas nitriding system with serial no.be-5078 including various constituant parts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 janv. 1991
    Livré le 30 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory and land at hortonwood 40 telford shropshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transactions
    • 30 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 déc. 1990
    Livré le 12 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The items as set out on the attached schedule (see form 395 for full details) the mortgage contains a covenant not to sell, transfer demise, let on hire or otherwise part with possession of the goods comprised in the mortgage charge, pledge lien or other encumbrance to arise in said goods.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 12 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 1990
    Livré le 12 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings comprising three acres on thereabouts at hortonwood, telford shropshire. The legal charge contains a covenant by the company not to sell encumber or otherwise deal with the equity of redemption in the property without the previous consent in writing of the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 12 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 nov. 1990
    Livré le 29 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the f/h property known as factory and land at hortonwood 40, telford shropshire goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mars 1990
    Livré le 04 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    78400 all monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the chargee.
    Brèves mentions
    See form 395 document M539 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • John Townleyas Trustees for the Tct Pension Fund
    • Ann Douglas
    • Richard Geoffrey Buster
    • David John Ashton
    Transactions
    • 04 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 19 mars 1990
    Livré le 27 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits, title and interest in and to a contract dated 19/3/90 and an agreement dated 19/3/90 in the works to be carried out at hortonwood 40 telford shropshire the company's rights, title and interest (if any) in hortonwood 40 telford shropshire described in an agreement dated 19/3/90. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 19 mars 1990
    Livré le 23 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 19 mars 1990
    Livré le 23 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transactions
    • 23 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0