MIDLAND NEWS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMIDLAND NEWS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02406962
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MIDLAND NEWS LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MIDLAND NEWS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MIDLAND NEWS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PIPMAY LIMITED21 juil. 198921 juil. 1989

    Quels sont les derniers comptes de MIDLAND NEWS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MIDLAND NEWS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mai 2016

    État du capital au 17 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward Alexander Graham le 06 mai 2016

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Stephen James Brown en tant que secrétaire le 06 mai 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Thomas William Graham en tant que directeur le 06 mai 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Edward Alexander Graham en tant qu'administrateur le 06 mai 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Thomas William Graham en tant qu'administrateur le 06 mai 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Thomas William Graham en tant qu'administrateur le 06 mai 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Phillip Antony Inman en tant qu'administrateur le 06 mai 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David James Hughes en tant que secrétaire le 30 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David James Hughes en tant que directeur le 30 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2015

    État du capital au 19 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Malcolm Gray Douglas Graham en tant que directeur le 23 mars 2015

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2014

    État du capital au 19 mai 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 29 déc. 2012

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approval of documents 02/07/2012
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MIDLAND NEWS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Stephen James
    51-53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Secrétaire
    51-53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    207939560001
    EVERS, Graham William
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Administrateur
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    EnglandBritish1518570006
    GRAHAM, Edward Alexander
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Administrateur
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish174816060001
    GRAHAM, Eric Alan
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Administrateur
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    FranceBritish1625250001
    GRAHAM, Thomas William
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Administrateur
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish198341640001
    INMAN, Phillip Anthony
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Administrateur
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish245426860001
    EVERS, Graham William
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    Secrétaire
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    British1518570002
    EVERS, Graham William
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    Secrétaire
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    British1518570002
    HUGHES, David James
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Secrétaire
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    British35966530003
    MILLARD, Andrew Clive
    44 Cranmere Avenue
    WV6 8TS Wolverhampton
    Secrétaire
    44 Cranmere Avenue
    WV6 8TS Wolverhampton
    British63339300001
    ALLATT, John David
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    Administrateur
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    British1518610001
    GRAHAM, Malcolm Gray Douglas
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Administrateur
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    United KingdomBritish1518600001
    GRAHAM, Thomas William
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Administrateur
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish207897700001
    HUGHES, David James
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Administrateur
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    EnglandBritish35966530003
    JACKSON, Brian Albert
    Tangalooma Caernarvon Lane
    Withington
    SY4 4PX Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    Tangalooma Caernarvon Lane
    Withington
    SY4 4PX Shrewsbury
    Salop
    British13597090001
    LIGGINS, Paul Warren
    8 Butt Lane
    Allesley
    CV5 9EU Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    8 Butt Lane
    Allesley
    CV5 9EU Coventry
    West Midlands
    British1622280001
    PARKER, John
    2 Vale Street
    Upper Gornal
    DY3 3XD Dudley
    West Midlands
    Administrateur
    2 Vale Street
    Upper Gornal
    DY3 3XD Dudley
    West Midlands
    British125618570001
    PARKER, Keith John
    94 Wrottesley Road
    Tettenhall
    WV6 8SJ Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    94 Wrottesley Road
    Tettenhall
    WV6 8SJ Wolverhampton
    West Midlands
    British56986510001
    WARD, Michael Arnold Charles
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    British32360190001
    WITTS, Anthony Martin
    Apartment 4 Sandringham Court
    Pengwern Road
    SY3 8LL Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Apartment 4 Sandringham Court
    Pengwern Road
    SY3 8LL Shrewsbury
    Shropshire
    British37615340002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MIDLAND NEWS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Claverley Group Limited
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    06 avr. 2016
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Register Of Companies For England & Wales
    Numéro d'enregistrement05213110
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MIDLAND NEWS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2009
    Livré le 04 janv. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Limited debenture
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 12 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Star Executive Pension Scheme and Includes the Trustees Thereof for Thetime Being
    Transactions
    • 12 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Limited debenture
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 12 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Star Group Pension Scheme and Includes the Trustee Thereof for the Timebeing
    Transactions
    • 12 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 06 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0