TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED

TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02407853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 oct. 2023
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 févr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 févr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 févr. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 11 avr. 2024

    3 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 mars 2024

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Alyson Elizabeth Mulholland en tant que secrétaire le 18 mars 2024

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Christopher Alan Hastings en tant que directeur le 28 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2024 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Paul Clarke en tant qu'administrateur le 31 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Colin Graham Dowsett en tant que directeur le 22 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2022

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2021

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2020

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2021 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Christopher Alan Hastings le 14 janv. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2019

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Christopher Alan Hastings le 15 janv. 2020

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB le 08 nov. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2018

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stuart Donald Cook en tant que directeur le 05 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARKE, Paul
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director318888510001
    DOREY, Laura Frances Christabel
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector230255280001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Tower House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East
    England
    England
    Secrétaire
    Tower House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East
    England
    England
    207967370001
    MULHOLLAND, Alyson Elizabeth
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    240507500001
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Administrateur
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritishCompany Solicitor145644720001
    BROWN, John Sydney
    15 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    15 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director58961420001
    CHESSMAN, Steven David Russell
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Administrateur
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    EnglandBritishSales Director135147710001
    COOK, Stuart Donald
    41 Tower Hill
    EC34 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    Administrateur
    41 Tower Hill
    EC34 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector191477240004
    COXON, David
    8 Eastern Terrace
    BN2 1DJ Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    8 Eastern Terrace
    BN2 1DJ Brighton
    East Sussex
    United KingdomBritishBanker121539300001
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant152332230001
    DUFFY, Paul James
    13 Clifford Road
    EN5 5PG New Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    13 Clifford Road
    EN5 5PG New Barnet
    Hertfordshire
    BritishAssistant Director2009170001
    GRIFFITHS, Michael John David, Mr.
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95344900001
    HAN, Philip James
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishA Director74160910001
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector64474720003
    HARRIS, Kevin Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170091040001
    HASTINGS, Christopher Alan, Mr.
    E14 4SG London
    One Bank Street
    United Kingdom
    Administrateur
    E14 4SG London
    One Bank Street
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Banker68475890002
    HOLME, Judith Angela
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance139386690001
    KEMP, Andrew John
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector222042280001
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    BritishAsst Managing Director4672880001
    MORRISON, Edward James
    Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    25
    Clackmannanshire
    Administrateur
    Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    25
    Clackmannanshire
    BritishBanker79242190002
    MORRISSEY, John Michael
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    MUNRO, Alan William Webster
    Rodene 4 Orchard Way
    Send Hill
    GU23 7HS Send
    Surrey
    Administrateur
    Rodene 4 Orchard Way
    Send Hill
    GU23 7HS Send
    Surrey
    BritishDirector1636910001
    PERRY, Michael Richard
    10 The Paddock
    Willaston
    CW5 7HJ Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    10 The Paddock
    Willaston
    CW5 7HJ Nantwich
    Cheshire
    BritishCompany Director102300002
    RITCHIE, Carol Ann
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director46402710001
    SKINNER, Trevor John
    2 Tudor Court
    B95 4AP Henly In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Tudor Court
    B95 4AP Henly In Arden
    Warwickshire
    BritishAssistant General Manager427570015
    TURNER, John Graham
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    Administrateur
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    EnglandBritishBanker35146920001
    WARD, Alexander Evelyn Giles
    Cornwell Grove
    Cornwell
    OX7 6TT Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Cornwell Grove
    Cornwell
    OX7 6TT Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishBanker57717950001
    WEBSTER, Alistair Linn
    7 Ettrick Road
    EH10 5BJ Edinburgh
    Administrateur
    7 Ettrick Road
    EH10 5BJ Edinburgh
    ScotlandBritishAccountant60101190002
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Leasing Structured Finance164554190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc327000
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1996
    Livré le 13 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility of even date and/or this deed and all other moneys due on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all properties plant & machinery securities debts insurances and any other asset entitlement benefit right or interest of any nature which the company from time to time has in relation to queens moat houses PLC or any of its assets.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the principal debtors to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TOWER HILL PROPERTY INVESTMENTS (10) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 mars 2024Commencement of winding up
    18 mars 2024Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0