M6 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM6 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02407928
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M6 LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe M6 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M6 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASPINCROFT LIMITED25 juil. 198925 juil. 1989

    Quels sont les derniers comptes de M6 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour M6 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2011

    3 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 nov. 2011

    4 pages4.68

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 nov. 2010

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de 42 Wigmore Street London W1U 2RY le 09 nov. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2010

    État du capital au 02 nov. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Salmaan Hasan le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy Claude Garnham le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ivan Howard Ezekiel le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ivan Howard Ezekiel le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2008

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages395

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 30 juin 2007

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de M6 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    British56155670004
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish66502160002
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritish106868320001
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    SHARP, Graham William
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Secrétaire
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    British13331010001
    YEWMAN, Steven John
    114 Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    Kent
    Secrétaire
    114 Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    Kent
    British45742320001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    British35406400003
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    Administrateur
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritish76373440001
    MOODY, Edward Robert William
    24 Coborn Street
    E3 2AB London
    Administrateur
    24 Coborn Street
    E3 2AB London
    Great BritainBritish62122950001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Administrateur
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritish118467060001
    SHARP, Graham William
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Administrateur
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    British13331010001

    M6 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and account charge
    Créé le 19 sept. 2008
    Livré le 25 sept. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its interest in the account meaning the account designated st botolphs deposit account number 45177301 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Agent and Security Trustee for the Beneficiaires (The Agent)
    Transactions
    • 25 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 2002
    Livré le 06 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 juil. 1996
    Livré le 31 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or minerva PLC to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    F/H property k/a 26,28 and 30 market street leicester t/nos:-LT40755 LT272410 and f/h property k/a 67 osborne road southsea portsmouth hampshire t/no:-HP404411. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 31 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 1994
    Livré le 22 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to chemical bank, as trustee for the beneficiaries (as defined) under or pursuant to a guarantee dated 8TH april 1994 and the debenture
    Brèves mentions
    F/H land k/as numbers 26, 28 and 30 market street, leicester t/nos LT40755 and LT19356 and various other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 22 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 1994
    Livré le 19 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to chemical bank as trustee for the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever under or pursuant to or as a result of any breach of, the loan agreement dated 19TH december 1989, the interest rate hedging agreement dated 20TH december 1989, the new interest rate hedging agreement and any other security document to which the company is a party
    Brèves mentions
    F/H land k/as numbers 26, 28 and 30 market street, leicester t/nos. LT40755 and LT19356 and various other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A letter of variation
    Créé le 04 févr. 1993
    Livré le 16 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A letter of variation to vary the terms of a loan agreement, a debenture and a deed of priorities d/d 19/12/89,and a legal charge d/d 20/12/89
    Brèves mentions
    All beneficial interests of the company in the assets charged and/or the proceeds of sale thereof (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank (As Security Agent)
    Transactions
    • 16 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over construction
    Créé le 21 déc. 1992
    Livré le 04 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The present or future obligations of the company and M1 limited (the borrowers) to chemical bank (as successor to manufacturers hanover trust company) (the security agent) as trustee for and on behalf of the beneficiaries or any of them pursuant to an agreement dated 19/12/89 and any other security documents to which the borrowers are a party
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the construction contract d/d 14/12/92 for the refurbishment of the ground floor offices at rockingham house 123 west street sheffield (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank (The Security Agent) as Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 04 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from minel limited pursuant to a facility agreement dated 19.12.89 to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Property discribed in the schedule of legal charge tog with all buildings erections trade & other fixtures plant & machinery the benefit of all rights claims guarantees and warrantees please see doc M44 for details.
    Personnes ayant droit
    • Elders Finance Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1989
    Livré le 21 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for and on behalf of the benificiaries as defined in the charge on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 19-12-89, the debenture, the interest rate hedging agreement dated 4-9-89 the legal charge or any other security document.
    Brèves mentions
    Several properties as listed on form 395THE benefit of all guarantees, warranties and rights etc. (please see doc M56 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Manufacturers Hanover Trust Company.
    Transactions
    • 21 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due to become due from minel LTD pursuant to a facility agreement dated 19.12.89
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Elders Finance Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 28 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 19.12.89
    Brèves mentions
    All property & assets as listed on schedule attached to doc m 314C.
    Personnes ayant droit
    • Minerva Corporation PLC
    Transactions
    • 28 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 28 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 19.12.89
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Minerva Corporation PLC
    Transactions
    • 28 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 21 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company as trustee for and on behalf of the beneficiaries as defined in the loan agreement dated 19TH december 1989 the interest rate hedging agreements dated 4TH september 1989 and any offer security document to which the borrower is a party to the chargee
    Brèves mentions
    (For full details see doc M197C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Manufactuers Hanover Trust Company.
    Transactions
    • 21 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    M6 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 mars 2012Dissolved on
    03 nov. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0