MARQUIS FILMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMARQUIS FILMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02413664
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MARQUIS FILMS LIMITED ?

    • Activités de production de films cinématographiques (59111) / Information et communication

    Où se situe MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    14 Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TANGOMERE LIMITED16 août 198916 août 1989

    Quels sont les derniers comptes de MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Nomination de Mr Mark Fisher en tant qu'administrateur le 02 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Fisher en tant que secrétaire le 30 déc. 2022

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Mark Fisher en tant que directeur le 30 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William George Hinshelwood en tant que directeur le 30 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2021

    2 pagesPSC09

    Notification de Winv Wide Llc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2020 au 31 déc. 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 juin 2019

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Vicki Christianson en tant que directeur le 07 mars 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Fisher en tant qu'administrateur le 07 mars 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 juin 2018

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Mark Fisher Flat 1, the Hollies St. Marys Lane Upminster Essex RM14 2QJ à 14 Arterial Avenue Rainham RM13 9NX le 19 déc. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 juin 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FISHER, Mark
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    Essex
    England
    Administrateur
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    Essex
    England
    EnglandBritish267889710001
    FISHER, Mark
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    Secrétaire
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    171174850001
    HINSHELWOOD, William George
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    Secrétaire
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    British36026700001
    RYMER, Philip Graham
    Etheldene Avenue
    Muswell Hill
    N10 3QH London
    50
    Secrétaire
    Etheldene Avenue
    Muswell Hill
    N10 3QH London
    50
    British137514930001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Secrétaire
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    123667200001
    BRADLEY, Jo Ann
    151a Longcroft Road
    Conifers
    S18 5SW Sheffield
    Administrateur
    151a Longcroft Road
    Conifers
    S18 5SW Sheffield
    British44824710001
    CHRISTIANSON, Vicki
    638 S Rossmore Ave
    FOREIGN Los Angeles
    California 90005
    United States
    Administrateur
    638 S Rossmore Ave
    FOREIGN Los Angeles
    California 90005
    United States
    United StatesAmerican102005790002
    DAVEY, Bruce Edwin Elwyn
    Wilshire Blvd
    Fourth Floor
    90401 Santa Monica
    808
    California
    Usa
    Administrateur
    Wilshire Blvd
    Fourth Floor
    90401 Santa Monica
    808
    California
    Usa
    United StatesAustralian104727180001
    FISHER, Mark
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    Administrateur
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    EnglandBritish267889710001
    HILL, Nicholas James
    23 Lambolle Place
    NW6 4PG London
    Administrateur
    23 Lambolle Place
    NW6 4PG London
    British87663590001
    HINSHELWOOD, William George
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    Administrateur
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    United KingdomBritish36026700001
    KAMP, Ralph Michael
    20 A The Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AR Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 A The Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AR Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish60794430001
    LEMLEY, James
    50 Courtfield Gardens
    Flat 2
    SW5 0ND London
    Administrateur
    50 Courtfield Gardens
    Flat 2
    SW5 0ND London
    American78406620001
    MAYSON, Andrew Graham
    Edwins Hall Edwins Hall Road
    Woodham Ferrers
    CM3 8RX Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Edwins Hall Edwins Hall Road
    Woodham Ferrers
    CM3 8RX Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish166543040001
    NORRIS, David John
    5 Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    5 Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish43802550001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Winv Wide Llc
    Wilshire Blvd
    Suite 400
    Santa Monica
    808
    Los Angeles
    United States
    06 avr. 2016
    Wilshire Blvd
    Suite 400
    Santa Monica
    808
    Los Angeles
    United States
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Corporation
    Autorité légaleLimited Liability Corporation
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour MARQUIS FILMS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 sept. 201630 déc. 2020La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées.

    MARQUIS FILMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge and deed of assignment
    Créé le 21 mai 1999
    Livré le 02 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums owing or payable to newmarket capital group L.L.C.pursuant to the loan agreement
    Brèves mentions
    By way of fixed and floating charge all that the chargor's right title and interest (whether now owned or hereafter acquired) excepting only the sv copyright interest throughout the territory in favour of the bank,in and to:- (a) all copies made or to be made of the film and of any such other films and sound recordings as are mentioned in clause 4.2 of the charge.(b) all sums relating to or derived from the film and from time to time standing to the credit of the chargor in any bank account.(c) all other rights and properties,including but not limited to physical properties acquired.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Newmarket Capital Group L.L.C.
    Transactions
    • 02 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge and deed of assignment
    Créé le 09 oct. 1998
    Livré le 14 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from icon distribution llc to the chargee under deed of assignment
    Brèves mentions
    By way of first fixed and floating all copies made or to be made of the film entitled 'felicia's journey' all sums relating to or derived from the film all other rights and properties the proceeds of any. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Newmarket Capital Group Llc
    Transactions
    • 14 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge and security assignment
    Créé le 15 mai 1996
    Livré le 24 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the producer's agreement and the performance of all representations,warranties,agreements,covenants and obligations under the producers agreement
    Brèves mentions
    In relation to the film all preprints elements capable of producing prints all positive prints all soundtrack elements the copyright of the film,the misic and compositions including the lyrics and all distribution and other rights relating to the film and by way of floating charge all the undertaking assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • International Film Guarantors L.P.
    • Firemans Fund Insurance Company
    Transactions
    • 24 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement and charge
    Créé le 24 mai 1990
    Livré le 07 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums which completion bond company inc. May be required to pay under the terms of a completion guarantee for the film "hamlet" and under the agreement and charge
    Brèves mentions
    The entire copyright throughout the world in the film "hamlet" and the approved screenplay for the film and any cinematograph films and sound recordings made in the course of the production of thefilm. (See form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Completion Bond Company Inc.
    Transactions
    • 07 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0