J. ROSENTHAL AND SON LIMITED

J. ROSENTHAL AND SON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ. ROSENTHAL AND SON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02415151
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    • Commerce de gros de textiles (46410) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Tabley Court
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPTWISE LIMITED21 août 198921 août 1989

    Quels sont les derniers comptes de J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 oct. 2021

    9 pagesLIQ03

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    7 pagesLIQ10

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 oct. 2020

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 54 158 Bury Road Radcliffe Manchester M26 2JR à 5 Tabley Court Victoria Street Altrincham Cheshire WA14 1EZ le 21 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    36 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    36 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2017 au 31 mars 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    34 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Jamieson en tant que directeur le 24 mars 2017

    2 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Nomination de Alan Jamieson en tant qu'administrateur le 25 avr. 2016

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROLLA, Gillian Denise
    Brandish
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    Brandish
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    British67844560002
    CROLLA, Gillian Denise
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    England
    Administrateur
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    England
    EnglandBritish67844560002
    MCLOUGHLIN, Jacqueline Anne
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Administrateur
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    United KingdomBritish151736120001
    POTTER, John Steven
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Administrateur
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish168496110001
    ROSENTHAL, Harry Ralph
    10 The Beeches
    Heald Road, Bowdon
    WA14 2HZ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    10 The Beeches
    Heald Road, Bowdon
    WA14 2HZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish46809940002
    ANDERSON, Neil
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Administrateur
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish174453210001
    BAILEY, Keith Andrew
    Treetop Main Road
    Little Haywood
    ST18 0TR Stafford
    Administrateur
    Treetop Main Road
    Little Haywood
    ST18 0TR Stafford
    EnglandBritish77732780002
    CRIBB, James
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    Administrateur
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    United KingdomBritish15119750004
    HAMILTON, John Peter
    Harden Road
    BB18 6TS Kelbrook
    The Old Co-Op 1
    Administrateur
    Harden Road
    BB18 6TS Kelbrook
    The Old Co-Op 1
    EnglandBritish129084320001
    HENDERSON, Francis
    22 Ellendale Grange
    Worsley
    M28 7UX Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    22 Ellendale Grange
    Worsley
    M28 7UX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish31481280001
    HILLIER, Paul Christopher
    57 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FE Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    57 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FE Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish66065810001
    HOYLE, Jacqueline Diane
    7 Christchurch Lane
    Harwood
    BL2 3QF Bolton
    Administrateur
    7 Christchurch Lane
    Harwood
    BL2 3QF Bolton
    United KingdomBritish77098160002
    JAMIESON, Alan
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Lancashire
    Administrateur
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Lancashire
    EnglandBritish209414830001
    KINGSLEY, Andrew Robert
    PO BOX 54
    158 Bury Road
    M26 2JR Radcliffe
    Manchester
    Administrateur
    PO BOX 54
    158 Bury Road
    M26 2JR Radcliffe
    Manchester
    United KingdomBritish3974060003
    WHITTLE, Simon Robert
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Administrateur
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish151744120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Andrew Peter Rigby
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    07 avr. 2016
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Harry Ralph Rosenthal
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    07 avr. 2016
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    J. ROSENTHAL AND SON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal assignment
    Créé le 30 nov. 2011
    Livré le 01 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 24 nov. 2011
    Livré le 26 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 26 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 21 nov. 2011
    Livré le 24 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transactions
    • 24 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 nov. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Britannia house 158 bury road radcliffe manchester t/n GM115898 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 nov. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    219 bury road radcliffe t/no GM906491 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 oct. 2007
    Livré le 17 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mr Harry Ralph Ross
    Transactions
    • 17 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 02 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Prospect mill walter street blackburn lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 janv. 2000
    Livré le 08 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being units 82, 83, 84 and 85 bison place moss side industrial estate leyland lancashire.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 avr. 1999
    Livré le 20 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date
    Brèves mentions
    Prospect mill walter st,blackburn lancashire; la 609520; all fixtures/fittings,fixed plant/machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Rexmore PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 déc. 1996
    Livré le 02 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 158 bury road radcliffe manchester t/no 115898 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 mars 1996
    Livré le 26 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 1995
    Livré le 01 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transactions
    • 01 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 mars 1995
    Livré le 04 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on book debts
    Créé le 10 août 1994
    Livré le 17 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A) by way of first fixed charge all book debts and other debts. B). by way of first floating charge the premises described in (a) above if and insofar as the charges thereon or any part thereof shall for any reason be in eneffective as fixed charges.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 17 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 1994
    Livré le 18 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Bank of Pakistan Limited
    Transactions
    • 18 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 1989
    Livré le 08 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    J. ROSENTHAL AND SON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 déc. 2022Due to be dissolved on
    16 oct. 2020Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Simister
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    practitioner
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Neil Henry
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    practitioner
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0