REGENERSIS (CREST) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREGENERSIS (CREST) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02420225
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REGENERSIS (CREST) LTD ?

    • (7260) /

    Où se situe REGENERSIS (CREST) LTD ?

    Adresse du siège social
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REGENERSIS (CREST) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CREST PERIPHERAL SERVICES LIMITED06 sept. 198906 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de REGENERSIS (CREST) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour REGENERSIS (CREST) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Gary Stokes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2010

    État du capital au 01 oct. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de David Kelham en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David William Kelham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Temple en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Sally Weatherall en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Kelham en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jeremy Michael Charles Wilson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes établis au 30 juin 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Statuts

    10 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed crest peripheral services LIMITED\certificate issued on 06/06/08
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Qui sont les dirigeants de REGENERSIS (CREST) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WEATHERALL, Sally
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    Secrétaire
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    152389720001
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    Administrateur
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    EnglandBritish151756520001
    BOWEN, John
    Flowergate 5 Heol Don
    Whitchurch
    CF14 2AR Cardiff
    Secrétaire
    Flowergate 5 Heol Don
    Whitchurch
    CF14 2AR Cardiff
    British33947050001
    CROCKER, Arthur Rupert
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    Secrétaire
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    British79797070001
    DALE, David Michael
    24 Ovitts Close
    Winslow
    MK18 3QD Buckingham
    Secrétaire
    24 Ovitts Close
    Winslow
    MK18 3QD Buckingham
    British13862480002
    MATTHEWS, Christopher John
    Duck Lane Cottage Duck Lane
    Maids Moreton
    MK18 1RG Buckingham
    Secrétaire
    Duck Lane Cottage Duck Lane
    Maids Moreton
    MK18 1RG Buckingham
    British59807870001
    ROBERTS, Christopher
    45 High Tree Drive
    Earley
    RG6 1EU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    45 High Tree Drive
    Earley
    RG6 1EU Reading
    Berkshire
    British19320020002
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    BAKER, John Frederick, Dr
    22 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LJ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    22 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LJ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish110330180001
    BROWN, Michael Anthony James
    Bienville Lower Common
    Eversley
    RG27 0QU Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Bienville Lower Common
    Eversley
    RG27 0QU Basingstoke
    Hampshire
    British58140050001
    CONAFRAY, Patrick John
    The Old Rickyard
    Sydenham Road
    OX39 4LR Sydenham
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Old Rickyard
    Sydenham Road
    OX39 4LR Sydenham
    Oxfordshire
    British111512810001
    CROCKER, Arthur Rupert
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    Administrateur
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    EnglandBritish79797070001
    DALE, David Michael
    24 Ovitts Close
    Winslow
    MK18 3QD Buckingham
    Administrateur
    24 Ovitts Close
    Winslow
    MK18 3QD Buckingham
    British13862480002
    KELHAM, David William
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    Administrateur
    4 Elm Place Old Witney Road,
    Eynsham, Witney
    OX29 4BD Oxfordshire
    EnglandBritish87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    MATTHEWS, Christopher John
    The Long House
    Hillesden Road, Gawcott
    MK18 4JF Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Long House
    Hillesden Road, Gawcott
    MK18 4JF Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59807870002
    ROBERTS, Christopher
    45 High Tree Drive
    Earley
    RG6 1EU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    45 High Tree Drive
    Earley
    RG6 1EU Reading
    Berkshire
    British19320020002
    ROBERTS, Dennis Colin
    3 Laniver Close
    Earley
    RG6 2UD Reading
    Berkshire
    Administrateur
    3 Laniver Close
    Earley
    RG6 2UD Reading
    Berkshire
    British22378850001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71396660002
    YOUNG, Keith Andrew
    11 Cowslip Crescent
    Thatcham
    Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    11 Cowslip Crescent
    Thatcham
    Newbury
    Berkshire
    British22378840003

    REGENERSIS (CREST) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 11 juin 1999
    Livré le 18 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 20 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 07 févr. 1995
    Livré le 20 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 15 nov. 1993
    Livré le 23 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 mai 1992
    Livré le 11 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rdm Factors Limited
    Transactions
    • 11 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 18 juin 1991
    Livré le 24 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brèves mentions
    All book and other debts owing the company.
    Personnes ayant droit
    • R D M Factors Limited
    Transactions
    • 24 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0