REGENERSIS (CREST) LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | REGENERSIS (CREST) LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02420225 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REGENERSIS (CREST) LTD ?
| Adresse du siège social | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REGENERSIS (CREST) LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour REGENERSIS (CREST) LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gary Stokes en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Kelham en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David William Kelham en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Temple en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Sally Weatherall en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Kelham en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jeremy Michael Charles Wilson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Statuts | 10 pages | MA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed crest peripheral services LIMITED\certificate issued on 06/06/08 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 403a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 403a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de REGENERSIS (CREST) LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEATHERALL, Sally | Secrétaire | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | 152389720001 | |||||||
| WILSON, Jeremy Michael Charles | Administrateur | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | England | British | 151756520001 | |||||
| BOWEN, John | Secrétaire | Flowergate 5 Heol Don Whitchurch CF14 2AR Cardiff | British | 33947050001 | ||||||
| CROCKER, Arthur Rupert | Secrétaire | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | British | 79797070001 | ||||||
| DALE, David Michael | Secrétaire | 24 Ovitts Close Winslow MK18 3QD Buckingham | British | 13862480002 | ||||||
| MATTHEWS, Christopher John | Secrétaire | Duck Lane Cottage Duck Lane Maids Moreton MK18 1RG Buckingham | British | 59807870001 | ||||||
| ROBERTS, Christopher | Secrétaire | 45 High Tree Drive Earley RG6 1EU Reading Berkshire | British | 19320020002 | ||||||
| TEMPLE, John Nicholas | Secrétaire | Windfalls Highfield Road West Moors BH22 0NA Ferndown Dorset | British | 84493950001 | ||||||
| BAKER, John Frederick, Dr | Administrateur | 22 Cherry Hill Road Barnt Green B45 8LJ Birmingham West Midlands | England | British | 110330180001 | |||||
| BROWN, Michael Anthony James | Administrateur | Bienville Lower Common Eversley RG27 0QU Basingstoke Hampshire | British | 58140050001 | ||||||
| CONAFRAY, Patrick John | Administrateur | The Old Rickyard Sydenham Road OX39 4LR Sydenham Oxfordshire | British | 111512810001 | ||||||
| CROCKER, Arthur Rupert | Administrateur | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | England | British | 79797070001 | |||||
| DALE, David Michael | Administrateur | 24 Ovitts Close Winslow MK18 3QD Buckingham | British | 13862480002 | ||||||
| KELHAM, David William | Administrateur | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | England | British | 87146390001 | |||||
| KELHAM, David William | Administrateur | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | 87146390001 | |||||
| MATTHEWS, Christopher John | Administrateur | The Long House Hillesden Road, Gawcott MK18 4JF Buckingham Buckinghamshire | England | British | 59807870002 | |||||
| ROBERTS, Christopher | Administrateur | 45 High Tree Drive Earley RG6 1EU Reading Berkshire | British | 19320020002 | ||||||
| ROBERTS, Dennis Colin | Administrateur | 3 Laniver Close Earley RG6 2UD Reading Berkshire | British | 22378850001 | ||||||
| STOKES, Gary Martin | Administrateur | 16a Fiery Hill Road Barnt Green B45 8LG Birmingham West Midlands | England | British | 71396660002 | |||||
| YOUNG, Keith Andrew | Administrateur | 11 Cowslip Crescent Thatcham Newbury Berkshire | British | 22378840003 |
REGENERSIS (CREST) LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 11 juin 1999 Livré le 18 juin 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 15 août 1997 Livré le 20 août 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 07 févr. 1995 Livré le 20 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 15 nov. 1993 Livré le 23 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 mai 1992 Livré le 11 mai 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 18 juin 1991 Livré le 24 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Brèves mentions All book and other debts owing the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0