VACATION CARE COMPUTING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | VACATION CARE COMPUTING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02422125 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VACATION CARE COMPUTING LIMITED ?
Adresse du siège social | Kettering Parkway Kettering NN15 6EY Northamptonshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VACATION CARE COMPUTING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour VACATION CARE COMPUTING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 oct. 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
État du capital au 16 févr. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 22 déc. 2020
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Clarke en tant que directeur le 04 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Joseph Mulcahy en tant qu'administrateur le 04 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Liggins en tant que directeur le 05 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Kettering Parkway Kettering Northamptonshire NN15 6EY | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2017 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de VACATION CARE COMPUTING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULCAHY, Paul Joseph | Administrateur | Kettering Parkway Kettering NN15 6EY Northamptonshire | England | Irish | Managing Director | 263639330001 | ||||
BANKES, Henry Francis John | Secrétaire | Cadeleigh Court Cadeleigh EX16 8RY Tiverton Devon | British | Company Secretary | 102155820002 | |||||
BANNISTER, Christopher Keith | Secrétaire | 535 Watford Road Chiswell Green AL2 3DU St. Albans Hertfordshire | British | 63470060001 | ||||||
BORGER, John Emory | Secrétaire | 13 Loch Lane FOREIGN Ledgewood 07852 New Jersey Usa | Us Citizen | Laywer | 85009370003 | |||||
BRIGGS, Martin Neil | Secrétaire | Muse Cottage 11 Church End Redbourn AL3 7DU St Albans Hertfordshire | British | 47985980001 | ||||||
NASTA, Marius Ion | Secrétaire | 44 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UT London | Belgian | 50087790005 | ||||||
R CURTIS, Ian Roy | Secrétaire | Flat 3 68 Lansdowne Street BN3 1FR Hove East Sussex | British | 95223130001 | ||||||
SMITH, Brian James | Secrétaire | 21a Glebe Road Purley On Thames RG8 8DP Reading Berkshire | British | 36381640001 | ||||||
SMITH, Trevor Robert | Secrétaire | 24 Plovers Mead Hook End CM15 0PS Brentwood Essex | British | 38682070001 | ||||||
TRIBBETT, Deryl Keith | Secrétaire | 815 St Paul Street FOREIGN Denver Colorado 80206 Usa | Us | 25550660001 | ||||||
WALSTER, Jacqueline | Secrétaire | 227 Maidenhead Road SL4 5HF Windsor Berkshire | British | Solicitor | 83670110001 | |||||
THE WOKING BUSINESS CENTRE LTD | Secrétaire | The Courthouse Erftstadt Court RG11 2AY Denmark Street Wokingham Berks | 31890370001 | |||||||
BANKES, Henry Francis John | Administrateur | Cadeleigh Court Cadeleigh EX16 8RY Tiverton Devon | England | British | Company Secretary | 102155820002 | ||||
BRENNAN, William Joseph | Administrateur | 28 Priory Road Kew TW9 3DH London | United States | Company Director | 97989400002 | |||||
CHAPMAN, Jeremy Simon | Administrateur | Rose Cottage Petworth Road Witley GU8 5PL Godalming Surrey | British | Company Director | 69220430001 | |||||
CLARKE, Andrew | Administrateur | Kettering Parkway Kettering Venture Park NN15 6EY Kettering Haylock House England | England | British | Director | 236497050001 | ||||
DEUTSCH, Franz Markus | Administrateur | Kelmarsh Hall The North Pavillion Main Road, NN6 9LY Kelmarsh Northamptonshire | Austrian | Chief Operating Officer | 78643290001 | |||||
DOBBS, Eric Duane | Administrateur | 6303 South Starlight Drive FOREIGN Morrison Colorado 80465 Usa | Us | Executive | 25550670001 | |||||
DOE, Paul John Jesse | Administrateur | 14 Hall Park Hill HP4 2NH Berkhamsted Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 39348560001 | |||||
FELLOWS, Roy Timothy | Administrateur | 10 Hall Lane NN15 7LJ Kettering Northamptonshire | England | British | Accountant | 47372740001 | ||||
FRASER, Simon Scott | Administrateur | Foxtrot 1 Shey Copse GU22 8HS Woking Surrey | British | Chief Financial Officer | 39862810001 | |||||
GERRARD, James Michael | Administrateur | 1 The Meadows Saddlestone Braddan ISLE MAN Isle Of Man | British | Chartered Accountant | 46085860001 | |||||
HAYLOCK, Julian Ronald | Administrateur | The Porch House Dingley Hall LE16 8PG Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 16696690001 | ||||
HITCHCOCK, Nelson | Administrateur | 57 Britton Street EC1M 5NA London | American | Director | 59223870001 | |||||
HUGHES, Andrew | Administrateur | 5 Middledale Road LE16 8FB Market Harborough Leicestershire | British | Chief Financial Officer | 75167870001 | |||||
LIGGINS, Andrew | Administrateur | Kettering Parkway Kettering NN15 6EY Northamptonshire | England | British | Accountant | 124162050002 | ||||
LIGGINS, Andrew | Administrateur | 4 Mulberry Court Drayton, Market Harborough LE16 8RG Leicestershire | England | British | Accountant | 124162050002 | ||||
MORRISROE, Frank | Administrateur | 846 Good Hope Drive 80104 Castle Rock Usa | American | Director | 50769000001 | |||||
R CURTIS, Ian Roy | Administrateur | Flat 3 68 Lansdowne Street BN3 1FR Hove East Sussex | British | Solicitor | 95223130001 | |||||
SWORDY, Stephen | Administrateur | La Maison Heathdown Road GU22 8LX Woking Surrey | British | Finance Director | 48946350001 | |||||
THOMAS, Duleep | Administrateur | Monastery Close Abbey Mill Lane AL3 4HA St Albans 4 United Kingdom | United States | Finance | 137345340001 | |||||
TOGERSON, John Dennis | Administrateur | 9177-F West Cedar Drive Lakewood Colorado 80226 FOREIGN Usa | Canadian | Company Director | 18088200002 | |||||
TRIBBETT, Deryl Keith | Administrateur | 815 St Paul Street FOREIGN Denver Colorado 80206 Usa | Us | Finance Director | 25550660001 | |||||
WALSTER, Jacqueline | Administrateur | 227 Maidenhead Road SL4 5HF Windsor Berkshire | British | Solicitor | 83670110001 | |||||
WILLIAMS, John David | Administrateur | Rowan House LE15 9PA Pilton Rutland | England | British | Operations Director | 86204260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VACATION CARE COMPUTING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rci General Holdco 2, Inc. | 06 avr. 2016 | Rodney Building #104 Wilmington De 19810 3411 Silverside Road United States | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
VACATION CARE COMPUTING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 27 févr. 1992 Livré le 06 mars 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the share sale agreement of even date | |
Brèves mentions All the company's fixed assets both present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0