SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED

SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02422757
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Adsetts House 16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROSKEL TRUSTEES LIMITED02 janv. 199002 janv. 1990
    TGP 223 LIMITED14 sept. 198914 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juin 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 juin 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juin 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Julie Ann Armstrong en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sarah Renton en tant que directeur le 01 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher David Lodge en tant que directeur le 01 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Ian Jackson en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Alexandra Lee Bailey en tant que directeur le 15 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Sarah Renton en tant qu'administrateur le 01 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher David Lodge en tant qu'administrateur le 01 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Watkins en tant qu'administrateur le 31 mars 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que directeur le 31 mars 2021

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kulbinder Kaur Dosanjh le 22 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant qu'administrateur le 18 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que directeur le 18 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Gregg Elliot
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    259409230001
    ARMSTRONG, Julie Ann
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish201601650001
    JACKSON, Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish186473820002
    WATKINS, Andrew
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish281612300001
    BARBER, Joanne
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Secrétaire
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    200049020001
    BOWER, Jannine Anne
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Secrétaire
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    172028690001
    HAGUE, Charlotte
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Secrétaire
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    181961560001
    JORDAN, Christopher
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    Secrétaire
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    British9841450001
    LINDLEY, Sarah
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    222280560001
    MONRO, Richard Charles
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Secrétaire
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    British59480370001
    SWYNNERTON, John Ralph
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    British2646260001
    APPLETON, George
    21 New Garden Street
    ST17 4DB Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    21 New Garden Street
    ST17 4DB Stafford
    Staffordshire
    British79234540001
    BAILEY, Alexandra Lee
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish239965330001
    BOWER, Jannine Anne
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Other125489700001
    DAVIES, Gareth Wyn
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish109674760001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish231199720003
    FORRESTER, William Wilson
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    Administrateur
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritish27743040001
    HEPWORTH, John Charles
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish154677690001
    JORDAN, Christopher
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    Administrateur
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    British9841450001
    LODGE, Christopher David
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish189424350001
    MANDER, Andrew
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish40579430008
    MARSHALL, Caroline
    15 Grenomoor Close
    Grenoside
    S35 8SD Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    15 Grenomoor Close
    Grenoside
    S35 8SD Sheffield
    South Yorkshire
    British117537310001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59480370001
    PAYTON, Roger Louis
    Little Bedwell Essendon
    Cucumber Lane
    AL9 6JA Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    Little Bedwell Essendon
    Cucumber Lane
    AL9 6JA Hatfield
    Hertfordshire
    British1866960001
    PRUST, Francis Charles
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    Administrateur
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    British54280001
    RENTON, Sarah
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish286855590001
    SKELDING, Simon
    Whitehay
    Withiel
    PL30 5NQ Bodmin
    Cornwall
    Administrateur
    Whitehay
    Withiel
    PL30 5NQ Bodmin
    Cornwall
    EnglandBritish76674530001
    WILLIAMS, David
    48 Wood Lane
    Wickersley
    S66 1JX Rotherham
    "Merrymede"
    South Yorkshire
    Administrateur
    48 Wood Lane
    Wickersley
    S66 1JX Rotherham
    "Merrymede"
    South Yorkshire
    EnglandEnglish127986830001
    ZAMBRA, Anthony Richard
    Balustrades Islet Park
    SL6 8LE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Balustrades Islet Park
    SL6 8LE Maidenhead
    Berkshire
    British10741010001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SIG GROUP LIFE ASSURANCE SCHEME TRUSTEES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01451007
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0