XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02424356 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Walbrook Building 25 Walbrook EC4N 8AQ London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Eric Dews en tant que directeur le 26 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX* le 07 avr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Timothy Llewellyn Croom en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Stephen Eric Dews en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Bligh en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Bligh en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Priggen en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Hobbs en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Gallagher en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROOM, Timothy Llewellyn | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 184906470001 | |||||
| CAMPBELL, Kenneth Francis | Secrétaire | 9 Cheldon Barton SS1 3TX Thorpe Bay Essex | British | 101302400001 | ||||||
| FUSSELL, Christopher Mark | Secrétaire | 2 Acris Street SW18 2QP London | British | 63476510003 | ||||||
| GALLAGHER, Anthony James | Secrétaire | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | Irish | 127048740001 | ||||||
| LONEY, Nicholas John | Secrétaire | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| SCORE, Timothy | Secrétaire | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| WILKINSON, Sidney James | Secrétaire | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||
| HEXAGON REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | Ten Dominion Street EC2M 2EE London | 4004080002 | |||||||
| BAUERNFEIND, David Gregory | Administrateur | The Coachouse Bathampton Lane BA2 6SW Bath | United Kingdom | British | 99529910001 | |||||
| BLIGH, Andrew William | Administrateur | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | United Kingdom | British | 165498010001 | |||||
| CAMPBELL, Kenneth Francis | Administrateur | 9 Cheldon Barton SS1 3TX Thorpe Bay Essex | British | 101302400001 | ||||||
| CAMPBELL-CARR, Richard Arthur | Administrateur | 9 Cardigan Avenue SS0 0SF Westcliff-On-Sea Essex | England | British | 32409630001 | |||||
| CROFT, David Richard | Administrateur | Brook House 21 Water Lane Steeple Bumpstead CB9 7DS Haverhill Suffolk | England | British | 44741010002 | |||||
| DEWS, Stephen Eric | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | 172816160001 | |||||
| DUNSTAN, Michael Ernest | Administrateur | 26 Plymtree Thorpe Bay SS1 3RA Southend On Sea Essex | British | 28712640001 | ||||||
| GOGEL, Robert Neil, Mr. | Administrateur | 16 Av Emile Deschanel FOREIGN Paris 75007 France | France | Us/French | 151744580001 | |||||
| GRAY, Shaun David | Administrateur | White Cottage Lower Chase Road SO32 2PB Swanmore Hampshire | England | British | 149960650001 | |||||
| HOBBS, Michael Owen | Administrateur | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | England | British | 28712650002 | |||||
| KNIGHT, Owen William | Administrateur | 51a Peartree Lane Danbury CM3 4LS Chelmsford Essex | British | 28495410001 | ||||||
| PRESLAND, Peter Eric | Administrateur | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | 7649630002 | |||||
| PRIGGEN, John Edward Frederick | Administrateur | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | England | British | 128934910003 | |||||
| SAFFER, Paul Graham | Administrateur | 5 Vulcan Gate Uplands Park Road EN2 7PP Enfield Middlesex | British | 60625080001 | ||||||
| SCORE, Timothy | Administrateur | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SHARP, Andrew Timothy | Administrateur | 53 Hillbury Road CR6 9TH Warlingham Surrey | United Kingdom | British | 330020620001 | |||||
| SISMEY, Malcolm | Administrateur | 24 Leeward Road South Woodham Ferrers CM3 5YR Chelmsford Essex | British | 55049310001 | ||||||
| SUMMERS, Roger Denis | Administrateur | Florins Birchwood Road Cock Clarks CM3 6PR Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 8559710002 | |||||
| TOBIN, Janice Annette | Administrateur | 1 Providence Square SE1 2EA London | England | British | 55049370003 |
XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A supplemental debenture | Créé le 09 juil. 1999 Livré le 28 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein) | |
Brèves mentions All freehold and leasehold property and all assets and undertakings. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 18 mars 1999 Livré le 30 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents as defined therein | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 oct. 1997 Livré le 13 nov. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0