XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED

XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéXCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02424356
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication
    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REBUS COMPUTER SERVICES LIMITED 15 août 199715 août 1997
    DATASURE LIMITED01 avr. 199701 avr. 1997
    DATASURE NOMINEES LIMITED31 janv. 199631 janv. 1996
    MARKETWIDE SYSTEMS LIMITED26 janv. 199026 janv. 1990
    EMBEX LIMITED19 sept. 198919 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2015

    État du capital au 01 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Stephen Eric Dews en tant que directeur le 26 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juin 2014

    État du capital au 02 juin 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX* le 07 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Timothy Llewellyn Croom en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Stephen Eric Dews en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Bligh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Nomination de Mr Andrew Bligh en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Priggen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Hobbs en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Gallagher en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Qui sont les dirigeants de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROOM, Timothy Llewellyn
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish184906470001
    CAMPBELL, Kenneth Francis
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    Secrétaire
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    British101302400001
    FUSSELL, Christopher Mark
    2 Acris Street
    SW18 2QP London
    Secrétaire
    2 Acris Street
    SW18 2QP London
    British63476510003
    GALLAGHER, Anthony James
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Secrétaire
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Irish127048740001
    LONEY, Nicholas John
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    Secrétaire
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    British8511300001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    HEXAGON REGISTRARS LIMITED
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    Secrétaire
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    4004080002
    BAUERNFEIND, David Gregory
    The Coachouse
    Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    Administrateur
    The Coachouse
    Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    United KingdomBritish99529910001
    BLIGH, Andrew William
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Administrateur
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    United KingdomBritish165498010001
    CAMPBELL, Kenneth Francis
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    Administrateur
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    British101302400001
    CAMPBELL-CARR, Richard Arthur
    9 Cardigan Avenue
    SS0 0SF Westcliff-On-Sea
    Essex
    Administrateur
    9 Cardigan Avenue
    SS0 0SF Westcliff-On-Sea
    Essex
    EnglandBritish32409630001
    CROFT, David Richard
    Brook House 21 Water Lane
    Steeple Bumpstead
    CB9 7DS Haverhill
    Suffolk
    Administrateur
    Brook House 21 Water Lane
    Steeple Bumpstead
    CB9 7DS Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritish44741010002
    DEWS, Stephen Eric
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    EnglandBritish172816160001
    DUNSTAN, Michael Ernest
    26 Plymtree
    Thorpe Bay
    SS1 3RA Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    26 Plymtree
    Thorpe Bay
    SS1 3RA Southend On Sea
    Essex
    British28712640001
    GOGEL, Robert Neil, Mr.
    16 Av Emile Deschanel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Administrateur
    16 Av Emile Deschanel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FranceUs/French151744580001
    GRAY, Shaun David
    White Cottage
    Lower Chase Road
    SO32 2PB Swanmore
    Hampshire
    Administrateur
    White Cottage
    Lower Chase Road
    SO32 2PB Swanmore
    Hampshire
    EnglandBritish149960650001
    HOBBS, Michael Owen
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Administrateur
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    EnglandBritish28712650002
    KNIGHT, Owen William
    51a Peartree Lane
    Danbury
    CM3 4LS Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    51a Peartree Lane
    Danbury
    CM3 4LS Chelmsford
    Essex
    British28495410001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Administrateur
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    PRIGGEN, John Edward Frederick
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Administrateur
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    EnglandBritish128934910003
    SAFFER, Paul Graham
    5 Vulcan Gate
    Uplands Park Road
    EN2 7PP Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    5 Vulcan Gate
    Uplands Park Road
    EN2 7PP Enfield
    Middlesex
    British60625080001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    SHARP, Andrew Timothy
    53 Hillbury Road
    CR6 9TH Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    53 Hillbury Road
    CR6 9TH Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish330020620001
    SISMEY, Malcolm
    24 Leeward Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 5YR Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    24 Leeward Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 5YR Chelmsford
    Essex
    British55049310001
    SUMMERS, Roger Denis
    Florins
    Birchwood Road Cock Clarks
    CM3 6PR Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Florins
    Birchwood Road Cock Clarks
    CM3 6PR Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish8559710002
    TOBIN, Janice Annette
    1 Providence Square
    SE1 2EA London
    Administrateur
    1 Providence Square
    SE1 2EA London
    EnglandBritish55049370003

    XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A supplemental debenture
    Créé le 09 juil. 1999
    Livré le 28 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    All freehold and leasehold property and all assets and undertakings.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture)
    Transactions
    • 28 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 mars 1999
    Livré le 30 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents as defined therein
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited(Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuant to the Facilities Agreement)
    Transactions
    • 30 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 1997
    Livré le 13 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0