MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED

MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02424725
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAMONCRAFT LIMITED20 sept. 198920 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Anthony John Mcveigh en tant que directeur le 01 oct. 2009

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    6 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 oct. 2012

    État du capital au 16 oct. 2012

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    8 pagesAA

    legacy

    10 pages395

    Qui sont les dirigeants de MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOBES, David Alan
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Secrétaire
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    British55316290002
    JOBES, David Alan
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish55316290002
    LEITCH, Roger Thomas
    Beech House43 Main Street
    Saxby All Saints
    DN20 0QF Brigg
    South Humberside
    Administrateur
    Beech House43 Main Street
    Saxby All Saints
    DN20 0QF Brigg
    South Humberside
    EnglandBritish94573040001
    COPLAND, Colin George
    Cranbrook House
    Redlands
    CR5 2HT Coulsdon
    Secrétaire
    Cranbrook House
    Redlands
    CR5 2HT Coulsdon
    British35697780002
    BRANT, Michael John
    332 Pelham Road
    Immingham
    DN40 1PU Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    332 Pelham Road
    Immingham
    DN40 1PU Grimsby
    South Humberside
    British19442910001
    COCKERTON, Timothy
    12 Clixby Close
    DN35 0HS Cleethorpes
    South Humberside
    Administrateur
    12 Clixby Close
    DN35 0HS Cleethorpes
    South Humberside
    British38630730001
    MCVEIGH, Anthony John
    42 Poplar Road
    Healing
    DN41 7RD Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    42 Poplar Road
    Healing
    DN41 7RD Grimsby
    North East Lincolnshire
    British55317410001
    MCVEIGH, Anthony John
    42 Poplar Road
    Healing
    DN41 7RD Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    42 Poplar Road
    Healing
    DN41 7RD Grimsby
    North East Lincolnshire
    British55317410001
    RYAN, Charles John
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    Administrateur
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    British21697760001

    MERCHANT MARINE SHIPPING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 10 oct. 2011
    Livré le 11 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Omnibus guarantee & set-off agreement
    Créé le 03 janv. 2006
    Livré le 05 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its credit balance and all other money and liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH june 1997 and
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 juin 1997
    Livré le 19 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of charge
    Créé le 12 oct. 1992
    Livré le 14 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 1992
    Livré le 13 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 05 déc. 1990
    Livré le 07 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 17 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0