MERCURY HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERCURY HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02425976
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERCURY HOLDINGS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe MERCURY HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Mountview Court 310 Friern Barnet Lane
    N20 0YZ Whetstone
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MERCURY HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERCURY AIRFREIGHT HOLDINGS LIMITED03 juil. 199003 juil. 1990
    ROLEROD LIMITED25 sept. 198925 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de MERCURY HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour MERCURY HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN le 27 avr. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 avr. 2012

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Dermot Francis Woolliscroft en tant que directeur le 10 avr. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Fink en tant que directeur le 10 avr. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Exel Secretarial Services Limited en tant que directeur le 10 avr. 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Jane Sargeant en tant qu'administrateur le 10 avr. 2012

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 mars 2012

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c / cancel cap redemption reserve 15/03/2012
    RES13

    Cessation de la nomination de Exel Nominee No 2 Limited en tant que directeur le 01 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Dermot Woolliscroft en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Waters en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven Fink en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Exel Nominee No 2 Limited le 31 mai 2010

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Exel Secretarial Services Limited le 31 mai 2010

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Exel Secretarial Services Limited le 31 mai 2010

    2 pagesCH02

    Qui sont les dirigeants de MERCURY HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    Secrétaire
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement817717
    32524900007
    SARGEANT, Jane
    Friern Barnet Lane
    N20 0YZ Whetstone
    2 Mountview Court 310
    London
    Administrateur
    Friern Barnet Lane
    N20 0YZ Whetstone
    2 Mountview Court 310
    London
    United KingdomBritish134292740001
    TAYLOR, Paul
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish105652320001
    CARTWRIGHT, Michael John
    4 Douro Road
    GL50 2PQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    4 Douro Road
    GL50 2PQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British65540180001
    THOMAS, Christopher Henry
    Quarries
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Quarries
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    British3174810001
    WALLS, Kenneth Charles
    4 Squirrel Rise
    SL7 3PN Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    4 Squirrel Rise
    SL7 3PN Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    British24310840002
    BROWN, Peter Frederick
    Lindrick
    Marlpit Close
    TN8 6BE Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Lindrick
    Marlpit Close
    TN8 6BE Edenbridge
    Kent
    British11464160001
    BUMSTEAD, Jonathan Culver
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish72820970001
    BUTTERFIELD, Michael John Brownrigg
    53 Hollycroft Avenue
    NW3 7QJ London
    Administrateur
    53 Hollycroft Avenue
    NW3 7QJ London
    English2304510001
    CARTWRIGHT, Michael John
    4 Douro Road
    GL50 2PQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    4 Douro Road
    GL50 2PQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British65540180001
    CHAMBERS, Alan James
    19 Mayes Close
    Mayes Place
    CR6 9LB Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    19 Mayes Close
    Mayes Place
    CR6 9LB Warlingham
    Surrey
    British21607620002
    FINK, Steven
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish158324340001
    GOLDSMITH, Brian Leslie
    65 Moor End
    SL6 2YJ Holyport
    Berkshire
    Administrateur
    65 Moor End
    SL6 2YJ Holyport
    Berkshire
    EnglandBritish101242590001
    HOWSE, Christopher John
    52 Gregories Road
    HP9 1HQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    52 Gregories Road
    HP9 1HQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish58746330001
    JAKES, Clifford Duncan
    Deeracres
    Lisle Court Road
    SO41 5SH Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Deeracres
    Lisle Court Road
    SO41 5SH Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish8426370002
    MATTHEWS, John Waylett
    Limpley Crest Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA2 7GW Bath
    Avon
    Administrateur
    Limpley Crest Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA2 7GW Bath
    Avon
    EnglandBritish28826190001
    PORTER, Melvin Robert
    Highfield House Manor Wood Gate
    Lower Shiplake
    RG9 3BY Henley On Thames
    Administrateur
    Highfield House Manor Wood Gate
    Lower Shiplake
    RG9 3BY Henley On Thames
    United KingdomBritish91881810001
    ROBINSON, Anthony John
    5 Simmons Place
    TW18 3HW Staines
    Middlesex
    Administrateur
    5 Simmons Place
    TW18 3HW Staines
    Middlesex
    English68016520002
    ROTHWELL, Donald Sidney
    Tamarisk
    Knotty Green
    HP9 2UA Beaconsfield
    Bucks
    Administrateur
    Tamarisk
    Knotty Green
    HP9 2UA Beaconsfield
    Bucks
    English812720001
    RUSSELL, Deborah Elizabeth
    63 Crofton Close
    RG12 0UT Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    63 Crofton Close
    RG12 0UT Bracknell
    Berkshire
    British59704430001
    SMITH, Ian Richard
    22 The Grange
    Wimbledon
    SW19 4PS London
    Administrateur
    22 The Grange
    Wimbledon
    SW19 4PS London
    United KingdomBritish181082310001
    THOMAS, Christopher Henry
    Quarries
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Quarries
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish3174810001
    THOMAS, Christopher Henry
    Quarries
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Quarries
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish3174810001
    WATERS, Christopher Stephen
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish54969250001
    WOOLLISCROFT, Dermot Francis
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish125837760001
    YOUNG, Stuart Anthony
    12 Darling House 35 Clevedon Road
    TW1 2TU Twickenham
    Administrateur
    12 Darling House 35 Clevedon Road
    TW1 2TU Twickenham
    EnglandEnglish47414200005
    EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    Administrateur
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1183615
    73807850002
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement817717
    32524900007

    MERCURY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment of life policy
    Créé le 09 avr. 1997
    Livré le 21 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or by the other borrowers (as defined)(or either of them) to the chargee under the facilities agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All its right,title and interest in and to the policy including all new and substituted policies relating thereto and all moneys including bonuses accrued or which may at any time hereafter accrue and which shall become patable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of life policies
    Créé le 24 mars 1997
    Livré le 02 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee by the company or by the other borrowers (as therein defined) (or either of them) (except for obligations and liabilities due owing or incurred to the chargee by the other borrowers as guarantor for the company) in whatever manner, including without prejudice to the generality of the foregoing under the facilities agreement (as therein defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns all right title and interest in and to the policies being: policy numbers 24069-088-das and 24068-088-das including all new and substituted policies relating thereto and all moneys including bonuses accrued thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 janv. 1997
    Livré le 10 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to each of the relevant agreements (as defined); and all monies due or to become due from any other company to the chargee under or pursuant to each of the relevant agreements (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 24 janv. 1997
    Livré le 10 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness and obligations of the company to the chargee under the facilities agreement of even date and the relevant agreements (as defined)
    Brèves mentions
    By clause 2 of the pledge agreement the pledgor pledged and granted to the bank the pledged shares being all of the issued and outstanding shares of common stock of mercury holdings inc. And the proceeds thereof together with any shares issued by way of stock dividend split or other distribution or reclassification. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 mai 1990
    Livré le 18 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details see form M395 reference M44L and continuation sheet). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Industrial Development Limited
    Transactions
    • 18 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 mai 1990
    Livré le 08 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 mai 1990
    Livré le 04 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stock-in-trade work-in-progress prepayments, investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 04 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MERCURY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 sept. 2013Dissolved on
    19 avr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin John Atkins
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London N20 0yz
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London N20 0yz

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0