CARE IN BATHING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARE IN BATHING LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02426566
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARE IN BATHING LTD ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CARE IN BATHING LTD ?

    Adresse du siège social
    Unit 20-21 Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARE IN BATHING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PREMIER BATHROOMS LTD.17 oct. 199517 oct. 1995
    GULLYMERE LIMITED26 sept. 198926 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de CARE IN BATHING LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 août 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour CARE IN BATHING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Sotos Constantinides en tant qu'administrateur le 30 oct. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Michael Murray en tant que directeur le 18 oct. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 30 août 2022

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 août 2021

    3 pagesAA

    Nomination de Stephen Michael Murray en tant qu'administrateur le 18 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jeremy Simon Ling en tant que directeur le 16 nov. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 30 août 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2019

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jeremy Simon Ling en tant qu'administrateur le 01 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Lawrence Edward Warriner en tant que directeur le 17 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Bage en tant que directeur le 31 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Premier House Hewell Road Enfield Redditch Worcestershire B97 6BW à Unit 20-21 Padgets Lane Redditch B98 0RA le 29 août 2019

    1 pagesAD01

    legacy

    6 pagesRP04CS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2018

    25 pagesAA

    Cessation de Mobility Bathing Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2018

    3 pagesPSC07

    Qui sont les dirigeants de CARE IN BATHING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Administrateur
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    United KingdomBritish124622460002
    ELLIS, Lee Richard
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Administrateur
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish199559150001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    British48633500003
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Secrétaire
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    British48633500003
    BAGE, Kevin Bruce
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Administrateur
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish212484210001
    CHAPMAN, Richard Anthony
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish141406650001
    ELLIS, Steven
    Rose Cottage
    Main Street
    WR10 2LX Bishampton
    Worcestershire
    Administrateur
    Rose Cottage
    Main Street
    WR10 2LX Bishampton
    Worcestershire
    British84557420001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish150955160001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Administrateur
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    EnglandBritish48633500003
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish5663680011
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish5663680009
    FARMILOE, Philip Geoffrey
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritish23681750002
    GARDNER, John William
    9 Caynham Close
    Winyates West
    B98 0JF Redditch
    Administrateur
    9 Caynham Close
    Winyates West
    B98 0JF Redditch
    British53982190004
    HARVEY, Paul Andrew
    1 Manor Road
    B80 7NA Studley
    Warwickshire
    Administrateur
    1 Manor Road
    B80 7NA Studley
    Warwickshire
    EnglandEnglish50633130002
    HOWE, Michael
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish32724080002
    HURFURT, Gareth John
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish112699190001
    JUSTICE, Kevin Thomas
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish189302640001
    LING, Jeremy Simon
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Administrateur
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish267364260001
    MOSEDALE, Michael John
    44 Luddington Road
    B92 9QH Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    44 Luddington Road
    B92 9QH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14506050002
    MURRAY, Stephen Michael
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Units 20-21
    England
    Administrateur
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Units 20-21
    England
    EnglandBritish290563950001
    NEWBROOK, David
    5 Wasdale Court
    WR4 9YT Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    5 Wasdale Court
    WR4 9YT Worcester
    Worcestershire
    British28917950001
    PRICE, Richard Duncan
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish111545180001
    VAUGHAN, Andrew Derek
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish174693630001
    WARRINER, Lawrence Edward
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Administrateur
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    United KingdomBritish119997720001
    WATSON, Andrew Terence
    12 Battenhall Road
    WR5 2BL Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    12 Battenhall Road
    WR5 2BL Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish107091420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARE IN BATHING LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    31 août 2018
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05522263
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    06 avr. 2016
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10097440
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Hc1264 Limited
    Hewell Road
    Enfield
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    Worcester
    06 avr. 2016
    Hewell Road
    Enfield
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    Worcester
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleThe Law Of England And Wales
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies
    Numéro d'enregistrement10097440
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CARE IN BATHING LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 févr. 2018
    Livré le 05 mars 2018
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lonsdale Capital Partners LLP
    Transactions
    • 05 mars 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 21 févr. 2018
    Livré le 22 févr. 2018
    En cours
    Brève description
    The freehold property known as unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG and registered at the land registry with title number HW110381.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 22 févr. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 04 oct. 2016
    Livré le 06 oct. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All that freehold property known as premier house, unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch, worcestershire B97 6BG registered at the land registry under title number HW110381.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2016
    Livré le 20 juil. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A fixed and floating charge over all assets.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2016
    Livré le 31 mai 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG. Title number HW110381.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Catalyst Business Finance LTD
    Transactions
    • 31 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 avr. 2016
    Livré le 26 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Catalyst Business Finance LTD
    Transactions
    • 26 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 mars 2015
    Livré le 13 mars 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York Mellon London Branch as Security Trustee (As Security Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transactions
    • 13 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 27 oct. 2011
    Livré le 02 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H properties at unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge t/n WM884026, gainsborough house brickyard road aldridge and unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge west midlands and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transactions
    • 02 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Omnibus letter of set-off
    Créé le 24 oct. 2011
    Livré le 28 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 01 avr. 2011
    Livré le 18 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property at unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transactions
    • 18 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 avr. 2011
    Livré le 18 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transactions
    • 18 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Philip Farmiloe
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1999
    Livré le 13 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1, enfield industrial estate hewell road redditch worcestershire t/n HW110381.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1998
    Livré le 22 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381.
    Personnes ayant droit
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transactions
    • 22 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 1998
    Livré le 22 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company under the debenture
    Brèves mentions
    The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transactions
    • 22 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 mars 1995
    Livré le 29 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transactions
    • 29 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 16 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Floating charge on the undertaking property and uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transactions
    • 16 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mai 1993
    Livré le 09 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0