RETAIL DECISIONS IS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRETAIL DECISIONS IS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02427010
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARDCAST INFORMATION SERVICES LIMITED04 avr. 199604 avr. 1996
    CARDCAST LIMITED27 sept. 198927 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 sept. 2014

    État du capital au 29 sept. 2014

    • Capital: GBP .01
    SH01

    Nomination de Mr. Theodore F. Rodriguez en tant qu'administrateur le 12 août 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Scott William Behrens en tant qu'administrateur le 12 août 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Dennis P. Byrnes en tant qu'administrateur le 12 août 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Paul Thomalla en tant qu'administrateur le 12 août 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Robert Stanley en tant que directeur le 12 août 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neshia Michelle Batchasingh en tant que directeur le 12 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Dennis Patrick Byrnes en tant que secrétaire le 12 août 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Neshia Batchasingh en tant que secrétaire le 12 août 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr. David Graham King en tant qu'administrateur le 12 août 2014

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 août 2014

    • Capital: GBP 0.01
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 06/08/2014
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Carlyle Cyril Clump en tant que directeur le 28 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Robert Stanley en tant qu'administrateur le 26 nov. 2012

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BYRNES, Dennis Patrick
    6060 Coventry Drive
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Secrétaire
    6060 Coventry Drive
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    190297730001
    BEHRENS, Scott William, Mr.
    6060 Coventry Drivve
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Administrateur
    6060 Coventry Drivve
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Nebraska/UsaAmericanCorporate Executive169074620001
    BYRNES, Dennis P., Mr.
    6060 Coventry Drive
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Administrateur
    6060 Coventry Drive
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Nebraska/UsaAmericanCorporate Executive/Attorney168782040001
    KING, David Graham, Mr.
    Clarendon Road
    WD17 1FQ Watford
    55/57
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Clarendon Road
    WD17 1FQ Watford
    55/57
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Executive179322610001
    RODRIGUEZ, Theodore F., Mr.
    6060 Coventry Drive
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Administrateur
    6060 Coventry Drive
    68022 Elkhorn
    Aci Worldwide
    Nebraska
    Usa
    Massachusetts/UsaAmericanAttorney178764100001
    THOMALLA, Paul, Mr.
    Clarendon Road
    WD17 1FQ Watford
    55/57
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Clarendon Road
    WD17 1FQ Watford
    55/57
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Executive169006140001
    AINSWORTH-MORRIS, Richard
    21 Sarek Park
    NN4 9YA Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    21 Sarek Park
    NN4 9YA Northampton
    Northamptonshire
    BritishAccountant80972840001
    AMOS, Richard John
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector67950460002
    BATCHASINGH, Neshia
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    169909940001
    COOKE, Oliver Charles
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    Secrétaire
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    BritishCompany Director3643340001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    BritishGroup Finance Director45345090004
    GOOD, Thomas William
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    Secrétaire
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    British21310620003
    GOODEY, Thomas Walter
    11 Church Meadow
    Maidstone Road
    TN12 8DQ Horsmonden
    Kent
    Secrétaire
    11 Church Meadow
    Maidstone Road
    TN12 8DQ Horsmonden
    Kent
    British94496730001
    HAYES, Kevin Andrew
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    BritishDirector29737760001
    MARCHANT, Elizabeth Jane
    10 Harelands Close
    Horsell
    GU21 4NX Woking
    Surrey
    Secrétaire
    10 Harelands Close
    Horsell
    GU21 4NX Woking
    Surrey
    BritishChartered Accountant62140800001
    NEVILLE, Roger Drummond
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    Secrétaire
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    BritishCompany Director35529130001
    POOLEY, Graham Neil
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    Secrétaire
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    British38288020001
    WIGHTMAN, Iain Charles
    65 Marefield
    Lower Earley
    RG6 3DZ Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    65 Marefield
    Lower Earley
    RG6 3DZ Reading
    Berkshire
    British81324370001
    AMOS, Richard John
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director67950460002
    BATCHASINGH, Neshia Michelle
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Administrateur
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector150222160001
    CALLAHAN, Stephen James
    The White House
    Charney Bassett
    OX12 0EU Wantage
    Oxfordshire
    Administrateur
    The White House
    Charney Bassett
    OX12 0EU Wantage
    Oxfordshire
    BritishDirector59241360001
    CLARK, Gerard Mark
    Garlands Dean Lane
    Cookham
    SL6 9BE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Garlands Dean Lane
    Cookham
    SL6 9BE Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishSales And Marketing Manager31819910001
    CLUMP, Carlyle Cyril
    Block 11
    Portomaso
    PTM 01 St Julians
    Apartment 1112
    Malta
    Administrateur
    Block 11
    Portomaso
    PTM 01 St Julians
    Apartment 1112
    Malta
    MaltaBritishDirector61613210002
    COOKE, Oliver Charles
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    Administrateur
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    United KingdomBritishCompany Director3643340001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director45345090004
    GOLDSPINK, Mark Richard
    4 Springfield Road
    KT1 2SA Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    4 Springfield Road
    KT1 2SA Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishBusiness Director76852990003
    GOOD, Thomas William
    5 Burnet Close
    GU24 9PB West End
    Surrey
    Administrateur
    5 Burnet Close
    GU24 9PB West End
    Surrey
    BritishAccountant21310620004
    GOOD, Thomas William
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    Administrateur
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    BritishAccountant21310620003
    HENDRY, James Michael Graham
    15 Castle Green
    KT13 9QL Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    15 Castle Green
    KT13 9QL Weybridge
    Surrey
    BritishEngineer5444950001
    KNIGHT, Paul Anthony James
    33 Scotland Road
    LE16 8AX Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    33 Scotland Road
    LE16 8AX Market Harborough
    Leicestershire
    BritishOperations Director74949030001
    LEE, David William
    65 Cannonbury Avenue
    HA5 1TP Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    65 Cannonbury Avenue
    HA5 1TP Pinner
    Middlesex
    BritishFinancial Controller24876980001
    MCNAIR, Martin Alexander
    Highwood Lodge 31 Hampstead Lane
    N6 4RT London
    Administrateur
    Highwood Lodge 31 Hampstead Lane
    N6 4RT London
    BritishVenture Capital Investment Manager45711180001
    MILLS, John Eric
    5 Southfield
    Southwick
    BA14 9PN Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    5 Southfield
    Southwick
    BA14 9PN Trowbridge
    Wiltshire
    EnglishCompany Director7716640001
    NEVILLE, Roger Drummond
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    Administrateur
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant35529130001
    NEVILLE, Roger Drummond
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    Administrateur
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritishCompany Director35529130001

    RETAIL DECISIONS IS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture made between the company and national westminster bank PLC (the security trustee)
    Créé le 11 janv. 2000
    Livré le 17 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whether present and future, actual or contingent due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 19 févr. 1998
    Livré le 20 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilites whether present or future actual or contingent which may at the date of the debenture or at any time thereafter be or become owing or incurred by the company to the chargee as security trustee,issuing bank and the banks under or pursuant to any of a credit agreement dated 23RD january 1998,a fees letter,and any guarantees and any debenture executed as security for any of the obligations and liabilities of the company and the other companies within the same group under any of the foregoing documents (together the "financing documents") (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 05 mars 1993
    Livré le 10 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 mai 1990
    Livré le 18 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0