RETAIL DECISIONS IS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RETAIL DECISIONS IS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02427010 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?
Adresse du siège social | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr. Theodore F. Rodriguez en tant qu'administrateur le 12 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr. Scott William Behrens en tant qu'administrateur le 12 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr. Dennis P. Byrnes en tant qu'administrateur le 12 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr. Paul Thomalla en tant qu'administrateur le 12 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Robert Stanley en tant que directeur le 12 août 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Neshia Michelle Batchasingh en tant que directeur le 12 août 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Dennis Patrick Byrnes en tant que secrétaire le 12 août 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Neshia Batchasingh en tant que secrétaire le 12 août 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr. David Graham King en tant qu'administrateur le 12 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 13 août 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 4 pages | AC92 | ||||||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Carlyle Cyril Clump en tant que directeur le 28 févr. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Robert Stanley en tant qu'administrateur le 26 nov. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RETAIL DECISIONS IS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRNES, Dennis Patrick | Secrétaire | 6060 Coventry Drive 68022 Elkhorn Aci Worldwide Nebraska Usa | 190297730001 | |||||||
BEHRENS, Scott William, Mr. | Administrateur | 6060 Coventry Drivve 68022 Elkhorn Aci Worldwide Nebraska Usa | Nebraska/Usa | American | Corporate Executive | 169074620001 | ||||
BYRNES, Dennis P., Mr. | Administrateur | 6060 Coventry Drive 68022 Elkhorn Aci Worldwide Nebraska Usa | Nebraska/Usa | American | Corporate Executive/Attorney | 168782040001 | ||||
KING, David Graham, Mr. | Administrateur | Clarendon Road WD17 1FQ Watford 55/57 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Executive | 179322610001 | ||||
RODRIGUEZ, Theodore F., Mr. | Administrateur | 6060 Coventry Drive 68022 Elkhorn Aci Worldwide Nebraska Usa | Massachusetts/Usa | American | Attorney | 178764100001 | ||||
THOMALLA, Paul, Mr. | Administrateur | Clarendon Road WD17 1FQ Watford 55/57 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Executive | 169006140001 | ||||
AINSWORTH-MORRIS, Richard | Secrétaire | 21 Sarek Park NN4 9YA Northampton Northamptonshire | British | Accountant | 80972840001 | |||||
AMOS, Richard John | Secrétaire | 22 Collens Road AL5 2AJ Harpenden Hertfordshire | British | Director | 67950460002 | |||||
BATCHASINGH, Neshia | Secrétaire | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | 169909940001 | |||||||
COOKE, Oliver Charles | Secrétaire | Solelands Farm RH20 2LG West Chiltington | British | Company Director | 3643340001 | |||||
DRYSDALE, Clive Douglas | Secrétaire | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | British | Group Finance Director | 45345090004 | |||||
GOOD, Thomas William | Secrétaire | Kyndling 39a Cobbetts Walk GU24 9DU Bisley Surrey | British | 21310620003 | ||||||
GOODEY, Thomas Walter | Secrétaire | 11 Church Meadow Maidstone Road TN12 8DQ Horsmonden Kent | British | 94496730001 | ||||||
HAYES, Kevin Andrew | Secrétaire | 4 Elm Road SO22 5AG Winchester Hampshire | British | Director | 29737760001 | |||||
MARCHANT, Elizabeth Jane | Secrétaire | 10 Harelands Close Horsell GU21 4NX Woking Surrey | British | Chartered Accountant | 62140800001 | |||||
NEVILLE, Roger Drummond | Secrétaire | 97 Rous Road IG9 6BU Buckhurst Hill Essex | British | Company Director | 35529130001 | |||||
POOLEY, Graham Neil | Secrétaire | Orakau 12 Willow Walk GU28 0EY Petworth West Sussex | British | 38288020001 | ||||||
WIGHTMAN, Iain Charles | Secrétaire | 65 Marefield Lower Earley RG6 3DZ Reading Berkshire | British | 81324370001 | ||||||
AMOS, Richard John | Administrateur | 22 Collens Road AL5 2AJ Harpenden Hertfordshire | England | British | Finance Director | 67950460002 | ||||
BATCHASINGH, Neshia Michelle | Administrateur | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | United Kingdom | British | Director | 150222160001 | ||||
CALLAHAN, Stephen James | Administrateur | The White House Charney Bassett OX12 0EU Wantage Oxfordshire | British | Director | 59241360001 | |||||
CLARK, Gerard Mark | Administrateur | Garlands Dean Lane Cookham SL6 9BE Maidenhead Berkshire | England | British | Sales And Marketing Manager | 31819910001 | ||||
CLUMP, Carlyle Cyril | Administrateur | Block 11 Portomaso PTM 01 St Julians Apartment 1112 Malta | Malta | British | Director | 61613210002 | ||||
COOKE, Oliver Charles | Administrateur | Solelands Farm RH20 2LG West Chiltington | United Kingdom | British | Company Director | 3643340001 | ||||
DRYSDALE, Clive Douglas | Administrateur | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | England | British | Group Finance Director | 45345090004 | ||||
GOLDSPINK, Mark Richard | Administrateur | 4 Springfield Road KT1 2SA Kingston Upon Thames Surrey | England | British | Business Director | 76852990003 | ||||
GOOD, Thomas William | Administrateur | 5 Burnet Close GU24 9PB West End Surrey | British | Accountant | 21310620004 | |||||
GOOD, Thomas William | Administrateur | Kyndling 39a Cobbetts Walk GU24 9DU Bisley Surrey | British | Accountant | 21310620003 | |||||
HENDRY, James Michael Graham | Administrateur | 15 Castle Green KT13 9QL Weybridge Surrey | British | Engineer | 5444950001 | |||||
KNIGHT, Paul Anthony James | Administrateur | 33 Scotland Road LE16 8AX Market Harborough Leicestershire | British | Operations Director | 74949030001 | |||||
LEE, David William | Administrateur | 65 Cannonbury Avenue HA5 1TP Pinner Middlesex | British | Financial Controller | 24876980001 | |||||
MCNAIR, Martin Alexander | Administrateur | Highwood Lodge 31 Hampstead Lane N6 4RT London | British | Venture Capital Investment Manager | 45711180001 | |||||
MILLS, John Eric | Administrateur | 5 Southfield Southwick BA14 9PN Trowbridge Wiltshire | English | Company Director | 7716640001 | |||||
NEVILLE, Roger Drummond | Administrateur | 97 Rous Road IG9 6BU Buckhurst Hill Essex | England | British | Chartered Accountant | 35529130001 | ||||
NEVILLE, Roger Drummond | Administrateur | 97 Rous Road IG9 6BU Buckhurst Hill Essex | England | British | Company Director | 35529130001 |
RETAIL DECISIONS IS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture made between the company and national westminster bank PLC (the security trustee) | Créé le 11 janv. 2000 Livré le 17 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities whether present and future, actual or contingent due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 19 févr. 1998 Livré le 20 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilites whether present or future actual or contingent which may at the date of the debenture or at any time thereafter be or become owing or incurred by the company to the chargee as security trustee,issuing bank and the banks under or pursuant to any of a credit agreement dated 23RD january 1998,a fees letter,and any guarantees and any debenture executed as security for any of the obligations and liabilities of the company and the other companies within the same group under any of the foregoing documents (together the "financing documents") (the "secured obligations") | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 05 mars 1993 Livré le 10 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 mai 1990 Livré le 18 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0