BROADREACH GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROADREACH GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02427982
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROADREACH GROUP LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BROADREACH GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 12
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROADREACH GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROADREACH SERVICES LIMITED30 nov. 198930 nov. 1989
    LAWGRA (NO. 42) LIMITED29 sept. 198929 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de BROADREACH GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour BROADREACH GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    17 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    16 pagesLIQ10

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Stephanie Alison Pound le 23 mai 2023

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mars 2023

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    État du capital au 29 mars 2023

    • Capital: GBP 5.05
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium 27/03/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Consolidation et subdivision des actions au 27 mars 2023

    6 pagesSH02

    Statuts

    12 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Consolidate & sub divide 27/03/2023
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Consolidate and sub divide 27/03/2023
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 05 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    21 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2020

    31 pagesAA

    Cessation de la nomination de Simon Charles Kirkpatrick en tant que directeur le 27 août 2021

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BROADREACH GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Secrétaire
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5228356
    148474450001
    DICKINSON, Peter John Goddard
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish229653270003
    POUND, Stephanie Alison
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish213930870003
    WILLIAMS, Jeremy Mark
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish280831530001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    British47884750003
    BUSH, Daniel
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Secrétaire
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    241571580001
    POUND, Stephanie Alison
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Secrétaire
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    249813250001
    SHERIDAN, Janet Katherine
    Warren House 133 The Ridgeway
    EN6 4BG Northaw
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Warren House 133 The Ridgeway
    EN6 4BG Northaw
    Hertfordshire
    British9077160002
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    British16575040001
    BADCOCK, Benjamin Edward
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish125575240001
    BLACKBURN, Peter Edward
    1 The Old Orchard
    CV35 9RW Wellesbourne
    Warwickshire
    Administrateur
    1 The Old Orchard
    CV35 9RW Wellesbourne
    Warwickshire
    British75964810001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish47884750003
    BROADLEY, John Rodgers
    Whitethorn Sandpit Hall Road
    GU24 8HA Chobham
    Surrey
    Administrateur
    Whitethorn Sandpit Hall Road
    GU24 8HA Chobham
    Surrey
    EnglandBritish8554730002
    BUSH, Daniel
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Administrateur
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish182845350001
    CLARK, Philip George
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish113107230002
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Administrateur
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    British49800090001
    ELLIS, John Leslie
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish25380370003
    EVANS, David John
    Little Radley
    Mackerye End
    AL5 5DS Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Little Radley
    Mackerye End
    AL5 5DS Harpenden
    Hertfordshire
    British8554740001
    FELL, James Thomas
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Administrateur
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish178128810002
    KIRKPATRICK, Simon Charles
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    EnglandBritish233739330001
    LING, Christopher Adam
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Administrateur
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish183577980001
    MCCARTHY, Elizabeth Margaret
    Bramley Bungalow Potton Road
    PE19 4XJ St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Bramley Bungalow Potton Road
    PE19 4XJ St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish45028910001
    SHERIDAN, Janet Katherine
    Warren House 133 The Ridgeway
    EN6 4BG Northaw
    Hertfordshire
    Administrateur
    Warren House 133 The Ridgeway
    EN6 4BG Northaw
    Hertfordshire
    EnglandBritish9077160002
    SMITH, Roger John
    Gilvers
    AL3 8AD Markyate
    Hertfordshire
    Administrateur
    Gilvers
    AL3 8AD Markyate
    Hertfordshire
    EnglandBritish14247350001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BROADREACH GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Maclellan Group Limited
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    06 avr. 2016
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUk Company Law
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement02279581
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    BROADREACH GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 29 févr. 2000
    Livré le 03 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,750 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Rent deposit £19,750.
    Personnes ayant droit
    • Bridgestart Properties Limited
    Transactions
    • 03 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 26 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or batemans cleaning services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 juin 1998
    Livré le 26 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or broadreach leisure support services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 12 févr. 1992
    Livré le 14 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing the due performance and observance of the company's covenants as tenant to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brèves mentions
    The sum of £49,275 on deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Markheath Properties Limited
    Transactions
    • 14 févr. 1992Enregistrement d'une charge
    • 04 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 12 févr. 1992
    Livré le 14 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing the due performance and observance of the company's covenants as tenant to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brèves mentions
    The sum of £25,725 on deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Markheath Properties Limited
    Transactions
    • 14 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 1990
    Livré le 26 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BROADREACH GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mars 2023Commencement of winding up
    23 juil. 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Caroline Rifkind
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0