GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02428039 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | Wsp House 70 Chancery Lane WC2A 1AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
État du capital au 26 avr. 2021
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Christopher John Noble en tant que directeur le 02 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Miles Lawrence Barnard en tant qu'administrateur le 01 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Karen Anne Sewell en tant que secrétaire le 15 déc. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mark William Naysmith en tant qu'administrateur le 15 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Nabarro Llp 1 South Quay, Victoria Quays Wharf Street Sheffield S2 5SY England à Amber Court William Armstrong Drive Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YQ | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEWELL, Karen Anne | Secrétaire | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | 220922160001 | |||||||
| BARNARD, Miles Lawrence | Administrateur | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | England | British | 225925270001 | |||||
| NAYSMITH, Mark William | Administrateur | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | Scotland | British | 79793020003 | |||||
| BISSET, Graham Ferguson | Secrétaire | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | British | 56857830001 | ||||||
| JORDAN, Stephen James | Secrétaire | 83 Greenside Road W12 9JQ London | British | 47629650001 | ||||||
| O SULLIVAN, Christopher Shaun | Secrétaire | 97 High Street Wheatley OX33 1XP Oxford Oxfordshire | British | 44060060001 | ||||||
| PAUL, Malcolm Stephen | Secrétaire | Kimberley 4 Grove Shaw Kingswood Court KT20 6QL Tadworth Surrey | British | 3865030001 | ||||||
| SHERIDAN, Michael Kenneth | Secrétaire | Oakways Tubbs Lane, Highclere RG20 9PQ Newbury Berkshire | British | 66376420001 | ||||||
| BRIGGS, Michael George | Administrateur | Red Cottage Swan Lane TN8 6BA Edenbridge Kent | British | 2592990002 | ||||||
| BULL, Keith | Administrateur | Searchers Wildmoor Sherfield On Loddon RG27 0HQ Hook Hampshire | British | 56319300001 | ||||||
| COLE, Christopher | Administrateur | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | England | British | 39376270004 | |||||
| GILL, Peter Richard | Administrateur | 30 Sheen Common Drive TW10 5BN Richmond Surrey | United Kingdom | British | 35996320004 | |||||
| HODGKINSON, William George | Administrateur | Orchard Lea 20 Coldharbour Close RG9 1QF Hanley On Thames Oxfordshire | British | 20774120002 | ||||||
| HOLLAND, Alfred James | Administrateur | Little Aulderwood Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 26209570001 | ||||||
| JORDAN, Stephen James | Administrateur | 83 Greenside Road W12 9JQ London | British | 47629650001 | ||||||
| LAWRENCE, Eric Alexander | Administrateur | 14 Larkspur Close RG11 2NA Wokingham Berkshire | British | 46112760001 | ||||||
| NOBLE, Andrew Christopher John | Administrateur | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | United Kingdom | British | 192017410001 | |||||
| O'SULLIVAN, Kevin Patrick | Administrateur | 63a Abingdon Villas W8 6XA London | British | 36349950001 | ||||||
| OBRIEN, Michael John | Administrateur | 1 Hopcraft Lane Deddington OX15 0TD Banbury Oxfordshire | British | 68313790002 | ||||||
| PARKER, Eric Wilson, Sir | Administrateur | Crimbourne House Crimbourne Lane Green Wisborough RH14 0HR Billingshurst West Sussex | England | British | 36208980001 | |||||
| PAUL, Malcolm Stephen | Administrateur | Staplefield Road Cuckfield RH17 5HY Haywards Heath Henmead Hall West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 3865030002 | |||||
| PAWSEY, Peter Edward | Administrateur | The Tythe Barn Atch Lench WR11 5SP Evesham Worcestershire | British | 71208320001 | ||||||
| SHERIDAN, Michael Kenneth | Administrateur | Oakways Tubbs Lane, Highclere RG20 9PQ Newbury Berkshire | England | British | 66376420001 | |||||
| TETLEY, Andrew David Rycroft | Administrateur | 25 Ridgeway KT19 8LD Epsom Surrey | British | 5868740001 | ||||||
| TYRRELL, Andrew Peter, Dr | Administrateur | 77 Lower Road KT22 9HG Leatherhead Surrey | British | 5690930001 | ||||||
| WATTS, Roy, Sir | Administrateur | Baywell House Fawler Road Charlbury OX7 3AE Oxford Oxfordshire | British | 9294200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsp Group Limited | 06 avr. 2016 | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
GRAHAM CONSULTING GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Créé le 28 mai 2009 Livré le 30 mai 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Shares - wsp international management consulting limited 250,000 shares class £1 ordinary related rights and dividends see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 avr. 1997 Livré le 17 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 04 janv. 1995 Livré le 10 janv. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a telford house hulse road southampton hampshire t/no hp 12518 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 07 juin 1990 Livré le 13 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0