PINDAR PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPINDAR PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02428709
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PINDAR PLC ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PINDAR PLC ?

    Adresse du siège social
    C/O Kpmg Llp 1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PINDAR PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PINDAR GRAPHICS PLC17 nov. 198917 nov. 1989
    METROTAB PUBLIC LIMITED COMPANY 03 oct. 198903 oct. 1989

    Quels sont les derniers comptes de PINDAR PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour PINDAR PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 janv. 2013

    31 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 15 janv. 2013

    31 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 nov. 2012

    33 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 mai 2012

    33 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 avr. 2012

    État du capital au 16 avr. 2012

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 25 janv. 2012

    44 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    75 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    36 pages2.16B

    Cessation de la nomination de Jenna Holliday en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Thornburgh Road Eastfield Scarborough North Yorkshire YO11 3UY le 03 août 2011

    1 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    31 pagesMG01

    legacy

    31 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Andrew Holmes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    5 pagesMG01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2010

    27 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    26 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Charles David Holmes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PINDAR PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINDAR, George Thomas Ventress
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Administrateur
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    United KingdomBritish1020460001
    PINDAR, George Andrew
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Administrateur
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    EnglandBritish1120570003
    HOLLIDAY, Jenna Louise
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Secrétaire
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    British136386570001
    NOAKES, David Anthony
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    British54380850004
    WHITTAKER, Paul Meredith Allen
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    British29811100001
    WOOLLEY, Heather Caroline
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    British38563500003
    BROUGHAM, Martyn
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    Administrateur
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    British60080800002
    COWLEY, Christian Anthony
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish27271120001
    DALTON, Andrew Leslie
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    Administrateur
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritish116104960001
    DUGGLEBY, Paul Neil
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    Administrateur
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    United KingdomBritish42924780005
    GRAY, Richard David
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish56284200002
    HOLMES, Andrew Charles David
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish64104370003
    LONGBOTHAM, David George
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    Administrateur
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    British24899320001
    LUMBY, Richard Stephen
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    British5653290001
    MCFIE SNEDDON, Mark
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    Administrateur
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    British71831240001
    NIVEN, Fraser Irvine
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1245890002
    O'SULLIVAN, Paul Joseph
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    British39741380001
    PALFREY, David Gwyn
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    British1209930001
    PINDAR, George Andrew
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    British1120570001
    STREET, Nigel
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    Administrateur
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    British60080730002
    WHITE, John
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    British5503640001
    WILKINSON, Peter James
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    Administrateur
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    EnglandBritish70519070001

    PINDAR PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattels mortgage
    Créé le 19 mai 2011
    Livré le 27 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee assigns the items of equipment and/or other chattels described or referred to in the schedule being 4 sets of 5 bays adjustable botless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Chattel mortgage
    Créé le 19 mai 2011
    Livré le 27 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a specific first charge all right, title and interest in and to the equipment being 4 sets of 5 bays adjustable boltless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited and Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 27 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal assignment
    Créé le 06 mai 2011
    Livré le 07 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Chattel mortgage
    Créé le 16 juin 2004
    Livré le 21 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Heidelberg - five colour printing press / s/no: 537137; heidelberg - five colour printing press / s/no: 540261; heidelberg - five colour printing press / s/no: 537749; muller - saddle stitching machine / s/no: 91.06593/42.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 21 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 05 déc. 2003
    Livré le 06 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the undertaking, all assets now owned or hereafter acquired including the stock in trdae and its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transactions
    • 06 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 28 déc. 2000
    Livré le 28 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof muller martini tempo saddle stitcher equipped with four type 416 feeders streatmfeeders 3738, card folder 344, rapido stacker into FW67/FJK41 filmwrapping line and cohiba palletiser s/n SAP368060.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 28 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 14 févr. 2000
    Livré le 17 févr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement (including the associated rights as defined in the agreement) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 17 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 févr. 2000
    Livré le 15 févr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,217,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new man roland and web offset printing press type lithoman iv serial no 27666 with all accessories and component parts and all improvements and renewals with all books manuals and handbooks technical data drawings schedules and other documentation.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 13 janv. 1995
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new heidelberg 102 speedmaster five colour offset press model 102F + l cp tronic controlled 72 x 102CM with coating system, complete with CPC1-03 alcolor dampening and CPC4 plate registration device, serial no: 537137 together with ancillary equipment. One new CPC3-s plate image reader serial no: 0057 together with ancillary equipment.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 04 janv. 1995
    Livré le 04 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. One new heidelberg harris web offset press model M600, serial no:mc Y0057 no. 51, together with ancillary equipment, serial nos:0044 da, 0218 ma, 28 0006010, 180193, 197.01.0080& 550051 6/94. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 09 juil. 1991
    Livré le 10 juil. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1991Enregistrement d'une charge

    PINDAR PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 juil. 2011Administration started
    15 janv. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0