OFQUEST LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOFQUEST LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02429501
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OFQUEST LIMITED ?

    • (3614) /

    Où se situe OFQUEST LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Begbies Traynor 9th Floor
    Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OFQUEST LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DESKING SYSTEMS LIMITED17 oct. 199117 oct. 1991
    WELLPAY LIMITED05 oct. 198905 oct. 1989

    Quels sont les derniers comptes de OFQUEST LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2007

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour OFQUEST LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour OFQUEST LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2014

    21 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 déc. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 déc. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 déc. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juil. 2013

    18 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2012

    17 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2011

    5 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 18 juin 2010

    16 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    16 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 janv. 2010

    14 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 juil. 2009

    11 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    12 pages2.16B

    Résultat de la réunion des créanciers

    33 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    32 pages2.17B

    legacy

    2 pages288b

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de OFQUEST LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRAYSHAW, Neil Andrew
    3 Finchley Lane
    OX6 8AE Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    3 Finchley Lane
    OX6 8AE Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritish59805060001
    OFQUEST DIRECTOR LIMITED
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    Administrateur
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    101569120002
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British42890001
    BENNETT, Phillip James
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    British113393520001
    KING, Lorna
    Slade Road
    Stokenchurch
    HP14 3QH High Wycombe
    34
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Slade Road
    Stokenchurch
    HP14 3QH High Wycombe
    34
    Buckinghamshire
    British130153660001
    GWB SECRETARY LIMITED
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    83825250001
    OFQUEST SECRETARY LIMITED
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    Secrétaire
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    86085190002
    ALLEN, Christopher Taylor
    65 Seven Acres
    OX9 3JQ Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    65 Seven Acres
    OX9 3JQ Thame
    Oxfordshire
    British45256100001
    ATKIN, John Dudley
    Manor Farm
    Marston St Lawrence
    OX17 2DA Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Manor Farm
    Marston St Lawrence
    OX17 2DA Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish47046270004
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish42890001
    BENNETT, Phillip James
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113393520001
    DUFFY, Francis Patrick
    33 Tithebarn Road
    L34 0EU Knowsley Village
    Merseyside
    Administrateur
    33 Tithebarn Road
    L34 0EU Knowsley Village
    Merseyside
    EnglandBritish151944930001
    GARTLAND, Anthony
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    Administrateur
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    United KingdomBritish27652170001
    HADLEY, David John
    76 Old High Street The Slade
    Headington
    OX3 7HW Oxford
    Administrateur
    76 Old High Street The Slade
    Headington
    OX3 7HW Oxford
    British55574880002
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40164810001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40164810001
    HOYLE, Richard John
    Millstones Milner Lane
    Greetland
    HX4 8HP Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Millstones Milner Lane
    Greetland
    HX4 8HP Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish43591930001
    IRWIN, John David
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59361420001
    LAWSON, Ian Bruce
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    Administrateur
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    EnglandBritish79170680001
    MCDOUGALL, Andrew
    The Old School
    School Lane
    NG13 9ES Whatton In The Vale
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Old School
    School Lane
    NG13 9ES Whatton In The Vale
    Nottinghamshire
    EnglandBritish154053860001
    MILLS, Lawrence Anthony
    15 Mayfield Drive
    Brayton
    YO8 9JZ Selby
    North Yorkshire
    Administrateur
    15 Mayfield Drive
    Brayton
    YO8 9JZ Selby
    North Yorkshire
    United KingdomBritish165378540001
    PENTLAND, Ian William
    Steadwell House
    Church End
    MK18 5NU Leckhampstead
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Steadwell House
    Church End
    MK18 5NU Leckhampstead
    Buckinghamshire
    British33480180001
    ROE, David
    12 St George's Street
    PE9 2BJ Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    12 St George's Street
    PE9 2BJ Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish80567360002
    STANTON, Michael John
    16 Duxford Close
    B97 5BY Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    16 Duxford Close
    B97 5BY Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish114566620001
    WARD, Alan John
    6 Donegal Close
    Caversham
    RG4 5DT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    6 Donegal Close
    Caversham
    RG4 5DT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish70124690001
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    Administrateur
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish1955430002
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    Administrateur
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    British4777030001
    ZAVOS, Theodore
    Under Hill House Hundon Road
    Barnardiston
    CB9 7TJ Haverhill
    Suffolk
    Administrateur
    Under Hill House Hundon Road
    Barnardiston
    CB9 7TJ Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritish50583170001

    OFQUEST LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 14 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Gartland Whalley & Barker Limited
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 06 mars 2007
    Livré le 09 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gartland Whalley and Barker PLC
    Transactions
    • 09 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 24 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Gartland Whalley and Barker PLC
    Transactions
    • 24 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable mortgage of shares
    Créé le 04 déc. 2000
    Livré le 14 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the corporate guarantee
    Brèves mentions
    Shares in any relevant company and all dividends interest etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 14 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 déc. 2000
    Livré le 09 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 09 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 mai 2000
    Livré le 18 mai 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 07 avr. 2000
    Livré le 08 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 x new stefani edgebander s/no.AH1003262.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 juin 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or systems furniture limited and/or cooper & palmer limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 20 oct. 1994
    Livré le 08 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1992
    Livré le 14 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises off eastview terrace, north street, langley mill, derbyshire t/no. DY228442.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 oct. 1992
    Livré le 13 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 ref. M367C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 oct. 1991
    Livré le 18 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Crossley House Holdings Limited
    Transactions
    • 18 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OFQUEST LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 janv. 2009Administration started
    29 juin 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Rob Sadler
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    practitioner
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    Begbies Traynor
    9th Floor
    Bond Court
    Leeds Ls1 2jz
    practitioner
    Begbies Traynor
    9th Floor
    Bond Court
    Leeds Ls1 2jz
    2
    DateType
    29 juin 2010Commencement of winding up
    09 mars 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Rob Sadler
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    practitioner
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    practitioner
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0