MORTIMER SPINKS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMORTIMER SPINKS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02432139
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MORTIMER SPINKS LIMITED ?

    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication
    • Activités des agences de travail temporaire (78200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe MORTIMER SPINKS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MORTIMER SPINKS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAGPASS LIMITED13 oct. 198913 oct. 1989

    Quels sont les derniers comptes de MORTIMER SPINKS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MORTIMER SPINKS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mark Jonathan Garratt en tant qu'administrateur le 27 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mark Jonathan Garratt en tant que secrétaire le 27 avr. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jonathan Richard Ashcroft en tant que directeur le 27 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Richard Ashcroft en tant que secrétaire le 27 avr. 2017

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2016

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2016

    État du capital au 27 juin 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2015

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 oct. 2015

    État du capital au 13 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2014

    17 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY à 110 Bishopsgate London EC2N 4AY le 22 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2014

    État du capital au 22 sept. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 oct. 2013

    État du capital au 10 oct. 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2013

    16 pagesAA

    legacy

    10 pagesMG01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Resolution effect notwithstanding provisions company articles 05/02/2013
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Resolution effect notwithstanding any provisions of company articles 05/02/2013
    RES13

    Qui sont les dirigeants de MORTIMER SPINKS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    231362280001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director49452080003
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector229682100001
    WASSALL, Simon Mark
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    Administrateur
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector108449780001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British258414370001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director49452080003
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director49452080003
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director81663830001
    HANTON, Karen Anne
    11 Warwick Square Mews
    SW1V 2EL London
    Secrétaire
    11 Warwick Square Mews
    SW1V 2EL London
    BritishCompany Secretary318330001
    NORTHEY, David
    187 Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8NL London
    Secrétaire
    187 Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8NL London
    BritishChartered Accountant46276820002
    HARFORD NOMINEES LIMITED
    Harford House
    101-103 Great Portland Street
    W1N 6BH London
    Secrétaire
    Harford House
    101-103 Great Portland Street
    W1N 6BH London
    2134810001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director258414370001
    CRAWFORD, Thomas Francis Alexander
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    Administrateur
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    United KingdomBritishCompany Director3856480002
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director49452080003
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    BritishManaging Director81663830001
    HANTON, Karen Anne
    12 Crown Reach
    145 Grosvenor Road
    SW1V 3JU London
    Administrateur
    12 Crown Reach
    145 Grosvenor Road
    SW1V 3JU London
    BritishCompany Director318330003
    HIGGINS, David Charles
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    Administrateur
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    United KingdomBritishCompany Director33333910003
    NORTHEY, David
    128 Farnaby Road
    BR1 4BH Bromley
    Surrey
    Administrateur
    128 Farnaby Road
    BR1 4BH Bromley
    Surrey
    BritishChartered Accountant46276820003
    SINGER, David Ivan
    11 Kings Drive
    HA8 8EB Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    11 Kings Drive
    HA8 8EB Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritishRecruitment Consultant38583380003
    TREACHER, David Hedley
    Suite Goft House
    Byworth
    GU28 0HW Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Suite Goft House
    Byworth
    GU28 0HW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director80479660001

    MORTIMER SPINKS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 févr. 2013
    Livré le 21 févr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 mai 2005
    Livré le 17 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge by client on purchased debts which fail to vest and other debts and floating charge on banked proceeds of other debts
    Créé le 14 nov. 2001
    Livré le 27 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (as defined in the charge) for the purchase of debts (as defined in the agreement) or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge over any debt with its related rights purchased by the security holder pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason and any proceeds thereof; all indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever with related rights thereto other than the purchased debts and floating charge over all monies which the company may receive in respect of other debts.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 27 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 sept. 1997
    Livré le 24 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 juin 1995
    Livré le 07 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 18 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    The sum of £5,000 deposited.
    Personnes ayant droit
    • Stoll Moss Theatres Limited
    Transactions
    • 18 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 juin 1993
    Livré le 25 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0