TOWERITE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWERITE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02433029
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWERITE LIMITED ?

    • Collecte, traitement et distribution d'eau (36000) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe TOWERITE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    Kent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TOWERITE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWERITE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP à 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR le 15 juin 2016

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 nov. 2015

    État du capital au 16 nov. 2015

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2015 au 31 août 2015

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Hugh Francis Edmonds en tant que secrétaire le 14 mai 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que directeur le 30 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que secrétaire le 30 avr. 2015

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY à 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP le 01 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 janv. 2015

    État du capital au 31 janv. 2015

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    12 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 nov. 2013

    État du capital au 05 nov. 2013

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de John Dobson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Prowse en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John William Charles Charlton le 28 oct. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Hodgson le 28 oct. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TOWERITE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDMONDS, Hugh Francis
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Secrétaire
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    197706110001
    HODGSON, Richard George
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    England
    Administrateur
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    England
    EnglandBritishFinance Director155847280001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    England
    Secrétaire
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    England
    150983600001
    STEELE, Vanessa
    Elkington Road
    Welford
    NN6 9NT Northampton
    Top House Farm
    Northamptonshire
    Uk
    Secrétaire
    Elkington Road
    Welford
    NN6 9NT Northampton
    Top House Farm
    Northamptonshire
    Uk
    BritishOffice Manager96617370005
    TRINDER, Ruth Annette
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    British19376450003
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Administrateur
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishDirector94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector- Shared Services119598150002
    COOK, Richard Antony
    54 Wrawby Road
    DN20 8DT Brigg
    North Lincolnshire
    Administrateur
    54 Wrawby Road
    DN20 8DT Brigg
    North Lincolnshire
    EnglandBritishSales Manager96617510001
    DOBSON, John Teasdale
    Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    27
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    27
    Berkshire
    England
    EnglandBritishConsultant99903330001
    DOBSON, John Teasdale
    27 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    Administrateur
    27 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritishDirector99903330001
    GRIFFITHS, Selwyn Jonathan
    71 Landcross Drive
    NN3 3LN Northampton
    Administrateur
    71 Landcross Drive
    NN3 3LN Northampton
    United KingdomBritishManagement Consultant59340440002
    GRIFFITHS, Selwyn Jonathan
    1 Brendon Close
    Abington Vale
    NN3 3AQ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    1 Brendon Close
    Abington Vale
    NN3 3AQ Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector49864730001
    HUNTER, Michael Robert
    26 Crutchley Road
    RG40 1XD Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    26 Crutchley Road
    RG40 1XD Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector64053950001
    PROWSE, John
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    England
    Administrateur
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Executive Officer96786510001
    TEBBUTT, John Edward Graham
    Fairlawne 59 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Fairlawne 59 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AG Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director11439780001
    TRINDER, Philip James
    Glenrise
    70 Ecton Lane, Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Glenrise
    70 Ecton Lane, Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director74019280001
    TRINDER, Ruth Annette
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector19376450003
    WILKINSON, Michael Guyon
    4 Pounds Farm Cottage
    East Garston
    RG16 7HU Newbury
    Administrateur
    4 Pounds Farm Cottage
    East Garston
    RG16 7HU Newbury
    BritishTechnical Director36607460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOWERITE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Stirling Park, Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    06 avr. 2016
    Stirling Park, Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Non
    Forme juridiquePlc
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01635609
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TOWERITE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2010
    Livré le 12 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of keyman life policy, intimation dated 18 june 2004 and
    Créé le 18 juin 2004
    Livré le 22 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Company: scottish provident policy number: 13101232 date: 28/02/2003 sum: £225,000 life assured: philip james trinder together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2002
    Livré le 21 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 août 2000
    Livré le 12 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0