CASEWISE SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASEWISE SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02433240
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication
    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication

    Où se situe CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 The Green
    TW9 1PL Richmond
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CASEWARE LIMITED17 nov. 198917 nov. 1989
    RISETOLL LIMITED17 oct. 198917 oct. 1989

    Quels sont les derniers comptes de CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    30 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 déc. 2017

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    38 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Nomination de Pd Cosec Limited en tant que secrétaire le 28 févr. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael Richard Hodes en tant que secrétaire le 28 févr. 2017

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 25 Grosvenor Street London W1K 4QN à 1 the Green Richmond Surrey TW9 1PL le 02 févr. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr James Mcgarry en tant qu'administrateur le 09 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Norman Campbell en tant qu'administrateur le 09 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bruce William Schnitzer en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alexandre Wentzo en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mahmood Ali Athar en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de George Arthur Keeling en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Richard Hodes en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2015

    40 pagesAA

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 oct. 2015

    État du capital au 22 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,180,488
    SH01

    Qui sont les dirigeants de CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PD COSEC LIMITED
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    England
    Secrétaire
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    England
    104364140001
    CAMPBELL, Richard Norman
    Mill Creek Drive
    Suite 155
    Laguna Hills
    23332
    California 92653
    United States
    Administrateur
    Mill Creek Drive
    Suite 155
    Laguna Hills
    23332
    California 92653
    United States
    United StatesCanadian221216210001
    MCGARRY, James
    Broadhollow Road
    Melville
    225
    New York
    United States
    Administrateur
    Broadhollow Road
    Melville
    225
    New York
    United States
    United StatesAmerican290097030001
    DONOGHUE, Andrew Paul
    Collier House
    169 Brompton Road
    SW3 1PY London
    Secrétaire
    Collier House
    169 Brompton Road
    SW3 1PY London
    British25045870004
    HODES, Michael Richard
    TW9 1PL Richmond
    1 The Green
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    TW9 1PL Richmond
    1 The Green
    Surrey
    United Kingdom
    British69083060002
    KEELING, George Arthur
    81 St Marys Mansions
    St Marys Terrace
    W2 1SY London
    Secrétaire
    81 St Marys Mansions
    St Marys Terrace
    W2 1SY London
    British16719000002
    ATHAR, Mahmood Ali
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    United KingdomBritish43150530001
    BURY, Lindsay Claude Neils
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    Administrateur
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish67103750001
    COHEN, Benjamin Charles
    38 Ripley Hill Road
    Concord
    Massachusetts 01742
    Usa
    Administrateur
    38 Ripley Hill Road
    Concord
    Massachusetts 01742
    Usa
    Canadian70827430003
    COLLINS, Christopher Alan
    Four Elms
    Grosvenor Road
    GU7 1PA Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Four Elms
    Grosvenor Road
    GU7 1PA Godalming
    Surrey
    EnglandBritish102328620001
    DONOGHUE, Andrew Paul
    Collier House
    169 Brompton Road
    SW3 1PY London
    Administrateur
    Collier House
    169 Brompton Road
    SW3 1PY London
    British25045870004
    DURHAM, Malcolm Gordon
    108 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RZ London
    Administrateur
    108 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RZ London
    United KingdomBritish40834260001
    ESIRI, Mark Leslie Vivian
    8 St Anns Road
    W11 4SR London
    Administrateur
    8 St Anns Road
    W11 4SR London
    United KingdomBritish115460060002
    FISHER, Bernard Robert
    Baker Street
    W1U 6AG London
    83
    England
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 6AG London
    83
    England
    United KingdomIrish54858230001
    GORMIN, Jonathan
    230 East 79th Street
    Apt.10f
    New York
    New York 10021
    Usa
    Administrateur
    230 East 79th Street
    Apt.10f
    New York
    New York 10021
    Usa
    American72835630001
    HODES, Michael Richard
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    United KingdomBritish69083060002
    KEELING, George Arthur
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    GermanyBritish16719000003
    MUELLER, Michael
    11 Andrew Reed Court
    Keele Close
    WD24 4RU Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 Andrew Reed Court
    Keele Close
    WD24 4RU Watford
    Hertfordshire
    German105793620001
    PEARMAN, Raymond Freddie
    Penmans Cottage
    South Park Avenue, Chorleywood
    WD3 5DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Penmans Cottage
    South Park Avenue, Chorleywood
    WD3 5DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    British66293320001
    POWELL, Simon Edward Meredith
    51 Somerset Road
    SW19 5HT London
    Administrateur
    51 Somerset Road
    SW19 5HT London
    United KingdomBritish64654650001
    SCHAGRIN, Bradley Mark
    33 Arborlane
    Levittown
    19055 Pennsylvania
    America
    Administrateur
    33 Arborlane
    Levittown
    19055 Pennsylvania
    America
    American71863100001
    SCHNITZER, Bruce William
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    England
    UsaAmerican161908110001
    WENTZO, Alexandre
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QN London
    25
    UsaFrench152617630001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CASEWISE SYSTEMS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    17 oct. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    CASEWISE SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 sept. 2015
    Livré le 01 oct. 2015
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2015
    Livré le 14 mai 2015
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 27 nov. 2012
    Livré le 07 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and assets present and future, including all real property, goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, all plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Faunus Group International, Inc.
    Transactions
    • 07 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 nov. 2003
    Livré le 22 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum £108,509.00 plus 17.5 % vat thereon being an amount equal to four months rent under the terms of the lease & which is deposited at barclays bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Gainsborough Awg Limited
    Transactions
    • 22 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 nov. 2001
    Livré le 07 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or casewise limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 avr. 1994
    Livré le 04 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the rent deposit deed (as defined therein)
    Brèves mentions
    The interest of the company in an interest earning deposit account opened by the chargee at its bank in which they have placed £5970.
    Personnes ayant droit
    • Frogmore Investments Limited
    Transactions
    • 04 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 mai 1992
    Livré le 26 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0