COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02433962 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED ?
Adresse du siège social | 11 Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling Kent England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 janv. 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 févr. 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 janv. 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Earl Sibley en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 13 pages | AA | ||||||||||
legacy | 216 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 janv. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Timothy Charles Lawlor en tant qu'administrateur le 12 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Bryan Carnegie en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 15 pages | AA | ||||||||||
legacy | 204 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cessation de Vistry Partnerships Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Countryside Properties (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed drew smith LIMITED\certificate issued on 18/01/23 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 27 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Daniel Munro en tant que directeur le 31 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 28 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Trevor Digby Palmer en tant que secrétaire le 25 juin 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Vistry Secretary Limited en tant que secrétaire le 25 juin 2021 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 024339620016 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Ms Clare Jane Bates en tant qu'administrateur le 25 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTRY SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent United Kingdom |
| 284895390001 | ||||||||||
BATES, Clare Jane | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Solicitor | 178363560001 | ||||||||
FARNHAM, Mark Robert | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Accountant | 97460130001 | ||||||||
LAWLOR, Timothy Charles | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Accountant | 302161610001 | ||||||||
TEAGLE, Stephen John | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Director | 79284370001 | ||||||||
DOSWELL, Andrew Johnathan | Secrétaire | Windward Norris Hill Bitterne Park SO18 1JH Southampton Hampshire | British | 36891180002 | ||||||||||
FOULKES, Neale Robert | Secrétaire | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | British | 50675870010 | ||||||||||
PALMER, Martin Trevor Digby | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | 265898320001 | |||||||||||
SMITH, Gary Eric | Secrétaire | 1 Lime Avenue Sholing SO19 8NY Southampton Hampshire | British | Builder | 70382040001 | |||||||||
GALLIFORD TRY SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Cowley Business Park, High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park England |
| 167168750001 | ||||||||||
ARCULUS, Peter Richard | Administrateur | 17 Sarum Close SO22 5LY Winchester Hampshire | England | British | Construction Director | 60717720002 | ||||||||
BRESLIN, Steven Mark | Administrateur | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park England | United Kingdom | British | Director | 184838470001 | ||||||||
CARNEGIE, Keith Bryan | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Solicitor | 265822400001 | ||||||||
CATOR, Adrian | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | British | Technical Director | 193854330001 | ||||||||
COOMBS, Garfield Leslie Powell | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Construction Director | 205100470001 | ||||||||
CORBETT, Kevin Allan | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | England | British | Director | 104676990002 | ||||||||
DOSWELL, Andrew Johnathan | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | British | Builder | 36891180007 | ||||||||
DYER, Mark William | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | British | Construction Director | 161488160001 | ||||||||
FANSTONE, Jeffery Colin | Administrateur | White Lodge Julian Close Chilworth SO16 7HR Southampton Hampshire | British | Chartered Surveyor | 14897380001 | |||||||||
FARMINER, Phillip Ian | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | British | None | 152084680001 | ||||||||
FOULKES, Neale Robert | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | British | Accountant | 50675870012 | ||||||||
GALLOWAY, Ian | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 279830460001 | ||||||||
GIBBONS, Stuart | Administrateur | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park England | England | British | Director | 92717280003 | ||||||||
JERRAM, Barry | Administrateur | 58 St Catherines Road Bitterne Park SO18 1LU Southampton Hampshire | British | Director | 75301480001 | |||||||||
MOODY, Thomas Robert | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Construction Director | 191546700001 | ||||||||
MUNRO, Stuart Daniel | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Company Director | 69420240004 | ||||||||
MUNRO, Stuart Daniel | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Quantity Surveyor | 69420240004 | ||||||||
PAYNE, Christopher Neil | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | British | None | 108157740001 | ||||||||
SIBLEY, Earl | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 196975430001 | ||||||||
SMITH, Gary Eric | Administrateur | Boxgrove House Jarvis Fields SO31 8AF Southampton Hampshire | British | Builder | 70382040004 | |||||||||
THAYNE, Iain Hugh, Me | Administrateur | Drew Smith House Mill Court The Sawmills Durley SO32 2EJ Southampton Hampshire | England | English | Construction | 146842090001 | ||||||||
TRUSCOTT, Peter Martin | Administrateur | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park England | United Kingdom | British | Director | 47020200012 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS SOUTHERN LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside Properties (Uk) Limited | 31 août 2023 | The Drive CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Vistry Partnerships Limited | 12 mai 2017 | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mrs Alison Louise Doswell | 06 avr. 2016 | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Andrew Johnathan Doswell | 06 avr. 2016 | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0