ROMAN RECOVERIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROMAN RECOVERIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02436236
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Whittington Hall
    Whittington Road, Whittington
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JUGWOOD PLC25 oct. 198925 oct. 1989

    Quels sont les derniers comptes de ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 14 déc. 2018

    • Capital: GBP 0.50
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium 11/12/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Andrew Reynolds le 09 nov. 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 25 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA

    Modification des détails de Pemberstone Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 janv. 2017

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 25 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2015

    État du capital au 30 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,584,449.5
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2014

    État du capital au 01 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,584,449.5
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Martin Barker le 18 juil. 2014

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 janv. 2014

    État du capital au 31 janv. 2014

    • Capital: GBP 1,584,449.5
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    2 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEMBERSTONE (SECRETARIES) LIMITED
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Secrétaire
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04002731
    77906620001
    ANNETTS, David Charles
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Administrateur
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector81373880001
    BARKER, Andrew Martin
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Administrateur
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector149813130009
    REYNOLDS, Mark Andrew
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Administrateur
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector41446640003
    LAWSON, Charles Bruce
    Council Buildings
    Teme Street
    WR15 8AA Tenbury Wells
    Hereford & Worcester
    Secrétaire
    Council Buildings
    Teme Street
    WR15 8AA Tenbury Wells
    Hereford & Worcester
    British21691000001
    CAPITAL VENTURES PLC
    Rutherford House
    Blackpole Road
    WR3 8YA Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    Rutherford House
    Blackpole Road
    WR3 8YA Worcester
    Worcestershire
    4933620008
    CIM MANAGEMENT LIMITED
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    70618260001
    ALCOCK, Timothy Robert
    11 Winchester House
    Cambridge Park
    TW1 2JG Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    11 Winchester House
    Cambridge Park
    TW1 2JG Twickenham
    Middlesex
    BritishDirector41515620003
    ANNETTS, David Charles
    The Snead
    Pensax
    WR6 6AG Abberley
    Worcestershire
    Administrateur
    The Snead
    Pensax
    WR6 6AG Abberley
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector81373880001
    BARKER, Andrew Martin
    Upper Birch Farm
    Shatterford
    DY12 1TR Bewdley
    Worcestershire
    Administrateur
    Upper Birch Farm
    Shatterford
    DY12 1TR Bewdley
    Worcestershire
    BritishDirector54622310001
    BRUCKLAND, Andrew John
    18 Eldorado Road
    GL50 2PT Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    18 Eldorado Road
    GL50 2PT Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishSolicitor22103780002
    FREDJOHN, Dennis
    Manor Park Place
    Rutherford Way
    GL51 9TR Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Manor Park Place
    Rutherford Way
    GL51 9TR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director35572390001
    INSCOE, Michael John
    Kingswood House
    Old Kingswood Road
    WV7 3AQ Albrighton
    Wolverhampton
    Administrateur
    Kingswood House
    Old Kingswood Road
    WV7 3AQ Albrighton
    Wolverhampton
    BritishCompany Director35547690001
    TWEEDALE, Roger
    86 Woodthorne Road South
    WV6 8SW Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    86 Woodthorne Road South
    WV6 8SW Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritishArchitect54065540002
    PEMBERSTONE (DIRECTORS) LIMITED
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Administrateur
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04234888
    82038280001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROMAN RECOVERIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Pgl (201) Limited
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    England
    06 avr. 2016
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrement2531045
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    ROMAN RECOVERIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 21 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 21 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of sub-charge
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 21 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the guarantee dated 3 june 1999 and under a loan agreement dated 24 february 1999
    Brèves mentions
    The chargor with full title guarantee sub-charged, conveyed, transferred and assigned to the society by way of first fixed security for the discharge and payment of the secured amounts (subject to the subsisting rights of redemption of borrowers (such term to mean, in relation to each mortgage, the person or persons referred to as the borrower in each such mortgage)) all right, title, interest and benefit of the chargor existing then or in the future in the mortgages such sub-charge shall be effected by the execution of the transfer (as defined in the deed) on the date of the deed subject to cesser on redemption.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 21 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 21 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999
    Brèves mentions
    The property known as albyn house hemel hempstead title number HD256878 for further property details see ch microfiche. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 21 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 11 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 11 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1999
    Livré le 16 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    24 second ave hendon london 21 william street ystrad rondda mid glam 35 leaford road kitts green burmingham 11 hamilton road topfham exeter for further details of all property charged please refer to form 395, with the goodwill of the business and the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 16 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mars 1998
    Livré le 07 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the east side of church side market weighton, l/h land at all saints court market weighton, f/h land on east side of archway market weighton, f/h land to the west of alexandra road hemel hempstead and f/h land at plots 1,2,3,13,14,15 & 16 leasowe road moreton wirral together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of all licences and registrations. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 07 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mars 1998
    Livré le 24 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (The "Agent") and the Lenders (as Defined)
    Transactions
    • 24 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 07 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 1 mereheath gardens moreton wiral merseyside t/n MS340503. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 07 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 3, 5, 7, 8, 10, 12 and 14 leasowe gardens mereheath moreton wirral merseyside. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 07 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a albyn house alexandra road hemel hempstead hertfordshire t/n HD256878. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 07 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h and l/h proeprty k/a all saints court market weighton east riding of yorkshire t/n's HS154780 (f/h) and HS200144 (l/h). And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 sept. 1997
    Livré le 07 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 1991
    Livré le 05 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 26-2-90
    Brèves mentions
    All saints court east side of church side market weighton east yorkshire humberside.
    Personnes ayant droit
    • Roman Homes PLC
    Transactions
    • 05 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 1990
    Livré le 05 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 26/2/90
    Brèves mentions
    Land & buildings east of church side market weighton east yorkshire t/n hs 154780.
    Personnes ayant droit
    • Roman Homes PLC
    Transactions
    • 05 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 nov. 1990
    Livré le 09 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 9 of an agreement dated 26-2-90.
    Brèves mentions
    F/H on west side of alexandra road hemel hempstead berkshire t/no hd 256878.
    Personnes ayant droit
    • Roman Homes PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0