DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED

DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02436465
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    • (6601) /

    Où se situe DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BLACKFRIARS FINANCIAL SERVICES LIMITED26 oct. 198926 oct. 1989

    Quels sont les derniers comptes de DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2011

    État du capital au 05 mai 2011

    • Capital: GBP 253
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jeremy Peter Small le 23 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    BritishCompany Director67168210001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFinancial Director79136250001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    BritishDirector130449650001
    STOTT, Wendy Mary
    Greenway Faulkners Lane
    Mobberley
    WA16 7AL Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    Greenway Faulkners Lane
    Mobberley
    WA16 7AL Knutsford
    Cheshire
    British21426440001
    CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    98153140001
    COLLETT, David John
    38 West Avenue
    BN11 5LT Worthing
    Sussex
    Administrateur
    38 West Avenue
    BN11 5LT Worthing
    Sussex
    BritishDirector84171690001
    COOPER, Ian Charles
    17 Abbey Road
    Sandbach
    CW11 3HA Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    17 Abbey Road
    Sandbach
    CW11 3HA Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director177014870001
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Blakemore House
    7 Oakley Manor Gardens Belle Vue
    SY3 7NT Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Blakemore House
    7 Oakley Manor Gardens Belle Vue
    SY3 7NT Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Director105488120002
    FINLOW, Michael Lewis
    The Coach House
    Abbey Fields Park Lane
    CW11 9EF Sandbach
    Cheshire
    Administrateur
    The Coach House
    Abbey Fields Park Lane
    CW11 9EF Sandbach
    Cheshire
    BritishCo Director5660760001
    FRAZER, Harris Allan
    41 Park Road
    Prestwich
    M25 0ES Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    41 Park Road
    Prestwich
    M25 0ES Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishCo Director31575950001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    UkBritishDirector98560430001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector130449650001
    SETH, Richard Andrew Errington
    Wensley 191 Chester Road
    Hazel Grove
    SK7 6EN Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Wensley 191 Chester Road
    Hazel Grove
    SK7 6EN Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishIndependent Financial Adviser57177190002
    SMITH, Angus
    The Lane
    Creeting St Peter
    IP6 8QR Ipswich
    Bonnybridge House
    Suffolk
    Administrateur
    The Lane
    Creeting St Peter
    IP6 8QR Ipswich
    Bonnybridge House
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director130809170001
    STOTT, Edward
    Greenway Faulkners Lane
    Mobberley
    WA16 7AL Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Greenway Faulkners Lane
    Mobberley
    WA16 7AL Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishCo Director21426430001
    STOTT, Wendy Mary
    Greenway Faulkners Lane
    Mobberley
    WA16 7AL Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Greenway Faulkners Lane
    Mobberley
    WA16 7AL Knutsford
    Cheshire
    BritishCo Secretary21426440001

    DESTINI BLACKFRIARS FINANCIAL PLANNING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of trail and renewal income
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the present and future rights titles and interests in and benefits of the company whatsoever in the trail & renewal income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential UK Services Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 02 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 07 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All sums together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of trail and renewal income
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 07 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the present and future rights titles and interests in the benefits of the company whatsoever in all and any commissions or other sums payable or due or becoming from or in relation to insurance's of whatever order arising from or in relation to insurance's of whatever kind, life policies, pensions of any kind, keyman policies, disablement policies, critical illness polices or any other policies, bonds, isa'S. Peps or other investment opportunities or any other insurance, assurance or investment opportunities whatsoever.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 1994
    Livré le 12 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 13 sept. 1990
    Livré le 28 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0