M4 ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM4 ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02438789
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M4 ESTATES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe M4 ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M4 ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRANMAC LIMITED01 nov. 198901 nov. 1989

    Quels sont les derniers comptes de M4 ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour M4 ESTATES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour M4 ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    21 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de * 4 Farm Street Mayfair London W1J 5RD* le 19 mai 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2014

    État du capital au 06 janv. 2014

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Période comptable actuelle prolongée du 31 janv. 2014 au 31 juil. 2014

    3 pagesAA01

    Comptes établis au 31 janv. 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Graham Hadden Dean Elliott le 08 oct. 2012

    3 pagesCH03

    Comptes établis au 31 janv. 2012

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Michael Francis Tweeddale-Tye le 06 déc. 2011

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes établis au 31 janv. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes établis au 31 janv. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes établis au 31 janv. 2009

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    6 pages363a

    Qui sont les dirigeants de M4 ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIOTT, Graham Hadden Dean
    31 Jersey Gardens
    SS11 7AG Wickford
    Oak Lodge
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    31 Jersey Gardens
    SS11 7AG Wickford
    Oak Lodge
    Essex
    United Kingdom
    British49198120003
    JONES, Stephen Douglas
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director8695620002
    TWEEDDALE-TYE, David Michael Francis
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    34
    United Kingdom
    Administrateur
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    34
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector111888220002
    WILSON, Andrew Luis
    Alassio
    243 Thorpe Hall Avenue
    SS1 3SG Thorpe Bay Southend
    Essex
    Administrateur
    Alassio
    243 Thorpe Hall Avenue
    SS1 3SG Thorpe Bay Southend
    Essex
    United KingdomBritishDirector31101960006
    CASS, Morris Gerald
    55 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    55 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    British2185920001
    JONES, Stephen Douglas
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    British8695620002
    WHITE, Timothy Scott
    Cornwall Road
    AL1 1SQ St Albans
    37
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Cornwall Road
    AL1 1SQ St Albans
    37
    Hertfordshire
    British94700490001
    CARRUTHERS, Stuart Andrew
    Halfpenny Cottage
    Buscot Wick
    SN7 8DJ Faringdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Halfpenny Cottage
    Buscot Wick
    SN7 8DJ Faringdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector25194620001
    FRYER, John Howard
    5 Keels
    Cricklade
    SN6 6NB Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    5 Keels
    Cricklade
    SN6 6NB Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector35423300001
    ROSE, Douglas George
    Vaikuntha Private Road
    Rodborough Common
    GL5 5BT Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Vaikuntha Private Road
    Rodborough Common
    GL5 5BT Stroud
    Gloucestershire
    BritishChartered Surveyor44226660001
    TAYLOR, Neal Anthony
    Weybridge Park
    KT13 8SJ Weybridge
    9
    Surrey
    Administrateur
    Weybridge Park
    KT13 8SJ Weybridge
    9
    Surrey
    EnglandEnglishDirector65914360002
    WILLIAMS, Peter John Marsden
    15 Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    Administrateur
    15 Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    EnglandBritishChartered Surveyor5311670001

    M4 ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 14 nov. 2001
    Livré le 20 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 22 avr. 1999
    Livré le 30 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a kode premises & site drakes way swindon wiltshire t/n WT138807. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rents agreement
    Créé le 21 juin 1995
    Livré le 01 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the mortgage debenture dated 21ST may 1992 and all deeds supplemental thereto (as defined in the rents agreement)
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest present and future to and in rent and all other monies due to tranmac limited under any leases or future leases in respect of the brunswick centre london. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 01 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation
    Créé le 21 juin 1995
    Livré le 01 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    And varying the terms of a mortgage debenture dated 21ST may 1992
    Brèves mentions
    All the companys right title and interests in an underlease of part of the lower basement car park comprising part of the brunswick centre london. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 01 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account charge deed
    Créé le 21 juin 1995
    Livré le 01 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company under the terms of the loan agreement dated 21ST june 1995 and all monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the account charge deed
    Brèves mentions
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the deposit account the rent account and the service charge account (as defined in the account charge deed and in the said loan agreement) togther with all interest account and all other assets of the company pursuant to the terms of the account charge deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 01 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of rental income
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 29 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to a mortgage debenture of even date
    Brèves mentions
    All those rents and other payments due at any time under the terms of the lease of the property k/a the brunswick centre t/n ngl 222023 see 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 29 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 29 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the property k/a the brunswick centre being land and buildings in marchmont street bernard street and brunswick square t/n NGL222023 together with all fixtures and fitings (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878) see form 395 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 29 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 29 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The sum or sums standing from time to time to the credit of deposit account number 001129931-102-00 see form 395 ref M540C.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 29 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 29 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The sum or sums standing to the credit of deposit account number 001129931-101- 00 see form 395 ref M537C.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 29 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 28 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum or sums standing from time to time to the credit of deposit account number 001129931-100-00 with credit lyonnaissee form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 28 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 19 mai 1992
    Livré le 29 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The sum or sums standing to the credit of account number 50881457 with the banksee form 395 ref M543C.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 29 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 juin 1991
    Livré le 13 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 1991
    Livré le 14 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The brunswick shopping centre london borough of camden t/no ngl 222023.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    M4 ESTATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 mai 2014Commencement of winding up
    11 sept. 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alex David Cadwallader
    One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    practitioner
    One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Neil A Bennett
    1 Great Cumberland Place
    London
    practitioner
    1 Great Cumberland Place
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0