VENTUREWORLD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVENTUREWORLD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02439474
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VENTUREWORLD LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe VENTUREWORLD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Foxhole Road Chorley
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de VENTUREWORLD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour VENTUREWORLD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 nov. 2010

    État du capital au 19 nov. 2010

    • Capital: GBP 2,302,272
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées du secrétaire John Clement Kay le 26 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr St John Stott le 26 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Clement Kay le 26 nov. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    10 pages395

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    15 pagesAA

    legacy

    6 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    14 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de VENTUREWORLD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    British27891540001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Administrateur
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Administrateur
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritish83024660001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    86d Whitley Crescent
    WN1 2PP Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    86d Whitley Crescent
    WN1 2PP Wigan
    Lancashire
    British32145610003
    LLOYD, Roger William
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    British123160110001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Secrétaire
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    BROOME, John Lawson
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    Administrateur
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    British67181090001
    FRANCE-HAYHURST, James Robert
    Mayfield House
    Bunbury
    CW6 9SY Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Bunbury
    CW6 9SY Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish73943640003
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Peter Graham
    Shannon Court Bowring Road
    IM8 2LQ Ramsey
    Isle Of Man
    Administrateur
    Shannon Court Bowring Road
    IM8 2LQ Ramsey
    Isle Of Man
    British16512550007
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KILBY, Eric Melvyn
    The Coach House
    Didsbury
    M20 0DA Manchester
    Administrateur
    The Coach House
    Didsbury
    M20 0DA Manchester
    British165870001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Administrateur
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritish83024660001
    SUNLEY, Anthony William
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    British6467980001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish2272770002

    VENTUREWORLD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 oct. 2006
    Livré le 24 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guild Ventures Limited
    Transactions
    • 24 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    1ST party commercial legal charge
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 18 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms and conditions as set out in this legal charge
    Brèves mentions
    F/H land on the south east of pit lane shipley derbyshire t/n-DY137890.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 06 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0