OSS ENVIRONMENTAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOSS ENVIRONMENTAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02440440
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    • Agents de commerce de combustibles, minerais, métaux et produits chimiques industriels (46120) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BCS FUELS LIMITED06 nov. 198906 nov. 1989

    Quels sont les derniers comptes de OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 28 févr. 2014

    20 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    23 pages2.35B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    36 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    7 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * Stockpit Road Knowsley Industrial Park Liverpool Merseyside L33 7TQ* le 04 oct. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 juin 2013

    État du capital au 26 juin 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pages395

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007

    9 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de OSS ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEES, Iain Roger
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    Secrétaire
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    British72628960001
    LEES, Iain Roger
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    Administrateur
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    EnglandBritish72628960001
    MCNAIR, Andrew Malcolm
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    United KingdomBritish68954380002
    FAGAN, Brian
    Lambay House, 2 Abbey Street
    Howth
    Dublin
    Ireland
    Secrétaire
    Lambay House, 2 Abbey Street
    Howth
    Dublin
    Ireland
    Irish58330390001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    British77855520001
    MCNAIR, Andrew Malcolm
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    British68954380002
    BEAUMONT, David Michael Leslie
    871 Manchester Road
    Linthwaite
    HD7 5NE Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    871 Manchester Road
    Linthwaite
    HD7 5NE Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish30052810001
    CACKETT, John William
    White House
    Barrison Green, Scarisbrick
    L40 8HX Ormskirk
    Lancashire
    Administrateur
    White House
    Barrison Green, Scarisbrick
    L40 8HX Ormskirk
    Lancashire
    British64146540001
    FACIAN, Brian
    4 Norbour View
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Administrateur
    4 Norbour View
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Irish28941990001
    GALLAGHER, Adrian
    83 Hollybank Road
    IRISH Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Administrateur
    83 Hollybank Road
    IRISH Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Irish13373910001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    British77855520001
    KIRRANE, Thomas
    1 Castlecove
    Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    1 Castlecove
    Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Irish1213760001
    PHILLIPS, John
    21 Beech Tree Close
    Oakley
    RG23 7EF Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    21 Beech Tree Close
    Oakley
    RG23 7EF Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish27081540001
    STURDY, Richard Alan
    Warren House Farm
    Galphay
    HG4 3PB Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Warren House Farm
    Galphay
    HG4 3PB Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish44637280001
    WILSON, Anthony
    34 Battenhall Rise
    WR5 2DE Worcester
    Hereford & Worcester
    Administrateur
    34 Battenhall Rise
    WR5 2DE Worcester
    Hereford & Worcester
    British54806510002

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 20 juil. 2009
    Livré le 23 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on north west side of barracks road sandy lane industrial estate titton stourport on seven t/n HW125790.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 02 mai 2002
    Livré le 02 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 02 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 oct. 2001
    Livré le 02 nov. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All liabilities and obligations due or to become due from the company to (1) the holders of the £4,774,000 8% loan stock 2009 ("loan stock") or any of them under the loan stock deed of even date or the loan stock and to (2) the security trustee under this instrument. (All terms as defined)
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all land now owned by the company. By way of first fixed equitable charge all land which, the company acquires in the future. By way of separate first fixed charges the goodwill and uncalled capital, the securities, insurances, intellectual property, debts, rents, asset contracts, other claims, fixed plant and equipment and the loose plant and equipment. By way of first floating charge all those assets which are not for any reason effectively charged by way of fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC ("Security Trustee" as Agent Andtrustee for Itself and Each of the Holders of the "Loan Stock")
    Transactions
    • 02 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of accession between the company oss group limited and dunedin enterprise investment trust PLC
    Créé le 12 juil. 2000
    Livré le 18 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future liabilities and obligations owed by the company to the stockholders (as defined) or any of them under the loan stock deed or the loan stock and to the chargee (the security trustee) under the guarantee and debenture dated 13 march 2000
    Brèves mentions
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 22 mai 2000
    Livré le 01 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and each other obligor (as defined) to the chargee under the finance documents (as defined) or any of them on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 01 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 sept. 1992
    Livré le 16 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 sept. 1992
    Livré le 16 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land at barracks road, stourport on severn in the county of worcestershire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 févr. 2014Administration ended
    06 sept. 2013Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0